ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03112560
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম এন.ই.সি. (96090) / অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Dock No. 1
    Chatham Docks
    ME4 4SW Chatham
    Kent
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NORDIC FOREST TERMINALS LIMITED০১ মার্চ, ১৯৯৬০১ মার্চ, ১৯৯৬
    ASTRAL RAM LIMITED১১ অক্টো, ১৯৯৫১১ অক্টো, ১৯৯৫

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১৪ থেকে ৩০ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ নভে, ২০১৪

    ০৭ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 300,000
    SH01

    ০৭ ফেব, ২০১৪ তারিখে Philip Andrew Taylor-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বিবিধ

    Section 519
    3 পৃষ্ঠাMISC

    পরিচালক হিসাবে Simon Lewis Collins-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Philip Andrew Taylor-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    পরিচালক হিসাবে Stuart Paterson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Perry Glading এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Charles Hammond এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Michael Kingston এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Pamela Smyth এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed nordic forest terminals LIMITED\certificate issued on 07/02/14
    4 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০৭ ফেব, ২০১৪

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ৩১ জানু, ২০১৪

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ অক্টো, ২০১৩

    ১৮ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 300,000
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ২৭ সেপ, ২০১৩ তারিখে Michael John Kingston-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ সেপ, ২০১৩ তারিখে Charles Graham Hammond-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COLLINS, Simon Lewis
    Tradescant Drive
    DA13 0EL Meopham
    1
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tradescant Drive
    DA13 0EL Meopham
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish83026730002
    TAYLOR, Philip Andrew
    Mackintosh Close
    High Halstow
    ME3 8EQ Rochester
    19
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Mackintosh Close
    High Halstow
    ME3 8EQ Rochester
    19
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish70375340003
    MCNEILL, Morag
    9 Wester Coates Gardens
    Wester Coates
    EH12 5LT Edinburgh
    সচিব
    9 Wester Coates Gardens
    Wester Coates
    EH12 5LT Edinburgh
    British2396760002
    SMYTH, Pamela June
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    সচিব
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    British172006950001
    STEWART, Toni Maria
    9 Northwood Avenue
    High Halstow
    ME3 8SX Rochester
    Kent
    সচিব
    9 Northwood Avenue
    High Halstow
    ME3 8SX Rochester
    Kent
    British16959850001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    সচিব
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    GLADING, Perry Dean
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    পরিচালক
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    EnglandBritish261672620002
    HAMMOND, Charles Graham
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    পরিচালক
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    ScotlandBritish498460009
    KINGSTON, Michael John
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    পরিচালক
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    UkBritish83677410001
    MURRAY, William Wilson
    35a Barnton Avenue West
    EH4 6DF Edinburgh
    পরিচালক
    35a Barnton Avenue West
    EH4 6DF Edinburgh
    United KingdomBritish498890002
    PATERSON, Stuart Randall
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    পরিচালক
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    ScotlandBritish64281400001
    PRICE, Colin John
    Orchard House
    164 Wateringbury Road
    ME19 6JD East Malling
    Kent
    পরিচালক
    Orchard House
    164 Wateringbury Road
    ME19 6JD East Malling
    Kent
    EnglandBritish147963010001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    পরিচালক
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    পরিচালক
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £12,000.00 due or to become due from the company to
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit and all interest.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Redington Design Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as land adjoining nos 6 and 7 berth chatham dockyard,gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as land to the north east of nos 6 and 7 berths at chatham docks gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £81,000 from the company to the chargee with interest and charges thereon
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first fixed charge over the goods listed in the schedule attached to the form 395.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Udt Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a berth 6, basin 3 chatham dockyard gillingham kent t/n K759631. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0