CHELSEA STORES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCHELSEA STORES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03123019
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CHELSEA STORES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CHELSEA STORES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CHELSEA STORES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DAISY & TOM LIMITED১৫ এপ্রি, ১৯৯৬১৫ এপ্রি, ১৯৯৬
    GEOPLITE LIMITED০৭ নভে, ১৯৯৫০৭ নভে, ১৯৯৫

    CHELSEA STORES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১২

    CHELSEA STORES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৭ মার্চ, ২০১৩ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ নভে, ২০১২

    ২০ নভে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 13,481,699.77
    SH01

    ২০ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Simon Harrington এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Harminder Singh Atwal-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    5 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Company business 11/04/2012
    RES13

    legacy

    19 পৃষ্ঠাMG01

    ২২ ফেব, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Helen Mary Bramall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ২২ ফেব, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Lynne Samatha Medini-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    পূর্ণ হিসাব ২৬ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Joanna Boydell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Neil Harrington-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ নভে, ২০১০ তারিখে Joanna Boydell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ নভে, ২০১০ তারিখে Helen Mary Bramall-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পরিচালক হিসাবে Mr Timothy John Ashby-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    CHELSEA STORES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MEDINI, Lynne Samatha
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    সচিব
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British167184950001
    ASHBY, Timothy John
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    পরিচালক
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Great BritainBritishGeneral Counsel162876770001
    ATWAL, Harminder Singh
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    পরিচালক
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishAccountant167976490001
    BRAMALL, Helen Mary
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary59695650001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত সচিব
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EMERSON, Matthew Charles
    12 Niton Road
    TW9 4LH Richmond
    Surrey
    সচিব
    12 Niton Road
    TW9 4LH Richmond
    Surrey
    British61777750001
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    সচিব
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    British116097830001
    MUGRIDGE, Nicholas John
    88 Durham Road
    East Finchley
    N2 9DS London
    সচিব
    88 Durham Road
    East Finchley
    N2 9DS London
    BritishChartered Accountant72460430004
    RAYNOR, Pamela Rose
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    সচিব
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    BritishFinance Director51267950001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    সচিব
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    UsFinance Director97940820001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    সচিব
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    British134102250001
    ALDWYCH SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    কর্পোরেট সচিব
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    4238520001
    BOYDELL, Joanna
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118883430001
    BROLLY, Brian Thomas
    Kitts Quarry
    Upton Bye Burford
    OX18 4LU Burford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Kitts Quarry
    Upton Bye Burford
    OX18 4LU Burford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director54192370002
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    মনোনীত পরিচালক
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GIFFIN, Michael William
    73c Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    পরিচালক
    73c Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    BritishAccountant73418870001
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director157815820001
    HOLMES, Andrew Peter Geoffrey
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    পরিচালক
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    EnglandBritishCompany Director21151650001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    পরিচালক
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritishCompany Secretary62634010001
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    পরিচালক
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    EnglandBritishFinance Director116097830001
    LANDERS, Brian James
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishProject Director Waterstone'S90246320001
    NEWMAN, Ian Kevin
    6 Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    6 Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    BritishIt Director145115790001
    RAINER, Michael James
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    পরিচালক
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    United KingdomBritishChartered Accounta14442650003
    RAWNSLEY, Janet Lynn
    Heywood Cottage
    6 Clifton Street
    SK9 7NW Alderley Edge
    Cheshire
    পরিচালক
    Heywood Cottage
    6 Clifton Street
    SK9 7NW Alderley Edge
    Cheshire
    BritishRetail Operation Director101826160001
    RAYNOR, Pamela Rose
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    পরিচালক
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    United KingdomBritishFinance Director51267950001
    REVETT, Clive Edward
    53 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    পরিচালক
    53 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Secretar16023450001
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Ashworth House
    Westonbirt
    GL8 8QJ Tetbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Ashworth House
    Westonbirt
    GL8 8QJ Tetbury
    Gloucestershire
    BritishCeo97170790001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    পরিচালক
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    UsFinance Director97940820001
    STEPHENSON, Elizabeth Jane
    92 Potter Street
    HA5 3XE Pinner
    Middlesex
    পরিচালক
    92 Potter Street
    HA5 3XE Pinner
    Middlesex
    BritishMerchandise Director79527850001
    THOMAS, Sian Elizabeth
    1 Olive Hill Cottages
    Wick Rissington
    GL54 2PW Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    1 Olive Hill Cottages
    Wick Rissington
    GL54 2PW Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishMarketing Director65979870001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director134102250001
    THOMSON, Christopher Harold William
    27 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    পরিচালক
    27 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    BritishCompany Director50470780001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63502600001
    WALSH, Wilfred Thomas
    Acorn Lodge
    Saint Huberts Lane
    SL9 7BP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Acorn Lodge
    Saint Huberts Lane
    SL9 7BP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director63955050003

    CHELSEA STORES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    181/183 kings road chelsea t/no BGL20895 118/124 deansgate and 44/56 king street west manchester t/no GM750858 and l/h 17/19 watergate row chester (for detailsof further properties charged please ref. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • D.C. Thomson & Company Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৬ মার্চ, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১২ জুন, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The indebtedness and the deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tcs Freehold Investments Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    181/183 kings road chelsea t/n BGL20895, 118/124 deansgate and 44/56 kkings street west manchester t/n GL750858, l/h land and buildings known as 17/19 watergate row chester, for details of further properties charged, please refer to form 39. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৬ মার্চ, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১২ জুন, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dc Thomson & Company Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dc Thomson & Company Limited and Quester Vct PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC ("the Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dc Thomson & Company Limited and Quester Vct PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies held in a rent deposit account under a rent deposit deed dated 02/08/02 in respect of 17-19 watergate row chester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Laura Ashley Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest in the deposit,as defined (in respect of the premises known as units WVL18 and WV02 weest mall bluewater kent). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Blueco Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dc Thomson & Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a daisy & tom limited to the chargee under the lease
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit and each and every debt represented by it. An initial deposit of £262,500.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 118-124 Deansgate Manchester Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the loan stock instrument
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dc Thomson & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £262,500 in an interest bearing designated account to be opened by the landlord with midland bank PLC, 1 sydney place, onslow square, south kensington, london SW7 3NW.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Xerox Pensions Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rental deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rent deposit of £49,790.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Princes Securities Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of rental deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company's interest in the deposit account as defined in the deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Computer Associates PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a 181 & 183 kings road chelsea london t/n BGL20895. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 118-124 (even) deansgate and 44-56 (even) king street west manchester t/n GM750858. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property at 181-183 kings road, london SW3 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 18TH march 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £24,357 rent and service charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tullo Marshall Warren Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rent deposit of £360,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Atlantic Speciality Retail Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Agreement for lease
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of clause 5 of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "performance deposit" being the sum of £360,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Atlantic Speciality Retail Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CHELSEA STORES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ মার্চ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৬ জানু, ২০১৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    অভ্যাসকারী
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0