VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03145771
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (8520) /

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Price Waterhouse Coopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VETERINARY BUSINESS CONSULTING LIMITED১২ জানু, ১৯৯৬১২ জানু, ১৯৯৬

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৪

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72

    ২২ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা4.68

    ২২ ফেব, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    ২২ আগ, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    15 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    15 পৃষ্ঠা2.34B

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    19 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    50 পৃষ্ঠা2.23B

    বিবৃতির বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    54 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHERIDAN, John Phillip
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    সচিব
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    British9358000001
    HOWARD, David Stewart
    Daglingworth House
    Church Road Daglingworth
    GL7 7AG Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Daglingworth House
    Church Road Daglingworth
    GL7 7AG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director44590450004
    SHERIDAN, John Phillip
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    BritishManagement Consultant9358000001
    TAYLOR, Andrew
    17 The Pastures
    Long Bennington
    NG23 5EG Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    17 The Pastures
    Long Bennington
    NG23 5EG Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishOperations Director95636700001
    TAYLOR, David John
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director91573380001
    BISHOP, Michael John
    Oak Cottage
    Park Lane
    EN10 7PQ Broxbourne
    Hertfordshire
    সচিব
    Oak Cottage
    Park Lane
    EN10 7PQ Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishFinance Director100911380001
    CARTWRIGHT, Richard Antony
    7 Highland Road
    HP7 9AU Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    7 Highland Road
    HP7 9AU Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector Of Finance95636770001
    FULTON, John
    25 The Orchards
    Eaton Bray
    LU6 2DD Dunstable
    Bedfordshire
    সচিব
    25 The Orchards
    Eaton Bray
    LU6 2DD Dunstable
    Bedfordshire
    British8846170001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত সচিব
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    HUTCHISON, Philippa Jane
    Maxey Hall
    Maxey
    PE6 9HF Peterborough
    Cambridgeshire
    সচিব
    Maxey Hall
    Maxey
    PE6 9HF Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishAdvertising Executive11590200001
    PARRY, Daniel Edward
    Ledborough Lodge
    Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    সচিব
    Ledborough Lodge
    Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    AmericanCfo60811110002
    SHERIDAN, John Phillip
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    সচিব
    Highbanks Bracken Lane
    Storrington
    RH20 3HR Pulborough
    West Sussex
    BritishManagement Consultant9358000001
    BEAUMONT, Peter Richard
    24 Laura Lane
    07960 Morris Township
    New Jersey
    Usa
    পরিচালক
    24 Laura Lane
    07960 Morris Township
    New Jersey
    Usa
    AmericanVeterinary Surgeon49221410001
    BISHOP, Michael John
    Oak Cottage
    Park Lane
    EN10 7PQ Broxbourne
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Oak Cottage
    Park Lane
    EN10 7PQ Broxbourne
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director100911380001
    CARTWRIGHT, Richard Antony
    7 Highland Road
    HP7 9AU Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    7 Highland Road
    HP7 9AU Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector95636770001
    COOPER, Ashley
    Iron Beech Cottage Parslows Hillock
    Lily Bottom Lane
    HP27 0RN Princes Risborough
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Iron Beech Cottage Parslows Hillock
    Lily Bottom Lane
    HP27 0RN Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director56376200003
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    BritishManaging Director53339290001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HUTCHISON, Douglas Chalmers
    Oakdene
    Argyll Road Kilcreggan
    G84 0JS Helensburgh
    Dunbartonshire
    পরিচালক
    Oakdene
    Argyll Road Kilcreggan
    G84 0JS Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishVeterinary Surgeon97132630001
    HUTCHISON, Philippa Jane
    Maxey Hall
    Maxey
    PE6 9HF Peterborough
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Maxey Hall
    Maxey
    PE6 9HF Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishAdvertising Executive11590200001
    MCKEEN, Richard Paul
    3 Hazell Park
    HP7 9AB Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    3 Hazell Park
    HP7 9AB Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director184297770002
    MONTAGU, Caroline
    24 Twilley Street
    SW18 4NS London
    London
    পরিচালক
    24 Twilley Street
    SW18 4NS London
    London
    BritishVeterinary Group77014080001
    NAGLE, John Joseph
    Apartment 100 The Elms
    Mount Merrion Avenue
    Dublin Ireland
    Republic Of Ireland
    পরিচালক
    Apartment 100 The Elms
    Mount Merrion Avenue
    Dublin Ireland
    Republic Of Ireland
    IrishCompany Director17054360001
    PARRY, Daniel Edward
    Ledborough Lodge
    Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ledborough Lodge
    Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    AmericanCfo60811110002

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £15,900.00 deposit. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Roger Freeman Ian Richard Wingate Wills and Michael Francis Townsend
    ব্যবসায়
    • ২৯ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date subject to a maximum of £6,500
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £6,500.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rilten Property Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 16TH august 1996 subject to a maximum of £1,600.00
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £1,600 standing in a separate designated interest earning bank account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Honourable Matthew White Ridley
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £101,250.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Bentley Errington
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,600.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £1,600.00 deposited in an interest bearing account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Honourable Matthew White Ridley
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed subject to a maximum of £18,300
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £18,300 held by the chargee in a deposit account with barclays bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • R Borras Construction Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole of the company's undertaking and all its property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Philip Hugh Harford Williams & Nicholas Michael Colwell
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • P.W.J.N. Buchanan and M.V. Buchanan
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that the interest of veterinary practice initiatives limited in a deposit account poened by darbys mallam lewis at national westminster bank PLC pursuant to and in accordance with the provisions of the rent deposit deed dated 29/10/99.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Douglas Roland Edward Jellis-Baldock, Michael John Clifton and Isabel Daphne Surman
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £2,400 due from the company to the chargee under the terms of a tenancy agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rent deposit £2,400.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Coad Trethewey
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,950 due from the company to the chargee under the terms of a tenancy agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rent deposit £1,950.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Coad Trethewey
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the acquisition agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge the whole of the company's property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Keith Mayer
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clauses 5.3.1(b) and 5.4 of an acquisition agreement of even date (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Christopher Bernard Rogers
    ব্যবসায়
    • ০২ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to clauses 5.3 1(b) and 5.4 (as the case may be) of an acquisition agreement (as such term is defined in the floating charge) and subject in all cases to the right of set-off set out in clause 5.8 of the acquisition agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge the whole of the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ceridwen Joan Andrews
    • Jon Michael Ruben
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £92,500 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jon Michael Ruben and Ceridwen Joan Andrews
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge.. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Colin Rex Chandler
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The keyman life policy issued by friends provident (policy no.11040310) in respect of john p sheridan for £250,000 running to 27 june 2006 and all sums assured by it and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a freehold property k/a kelperland farmhouse touchen end bray maidenhead berkshire t/n BK74423 and BK281011 and leasehold property k/a 280 dedworth road windsor berkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £95,937 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole of the borrower's undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Stephen Warnes Cooke
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    VETERINARY PRACTICE INITIATIVES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৩ আগ, ২০০৭প্রশাসন শেষ
    ১৫ সেপ, ২০০৬প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Robert William Birchall
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৭ জানু, ২০১০ভেঙে গেছে
    ২৩ আগ, ২০০৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Robert William Birchall
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Robert William Birchall
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0