TRIGON SNACKS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTRIGON SNACKS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03147034
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TRIGON SNACKS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য খাদ্য পণ্য উৎপাদন (10890) / উৎপাদন

    TRIGON SNACKS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Greater Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TRIGON SNACKS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SPEED 5327 LIMITED১৬ জানু, ১৯৯৬১৬ জানু, ১৯৯৬

    TRIGON SNACKS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০১২
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১৩
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    TRIGON SNACKS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৬ জানু, ২০১৭
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে৩০ জানু, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TRIGON SNACKS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TRIGON SNACKS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার - পূর্বে ঋণদাতাদের স্বেচ্ছায় দ্রবীভূতকরণে

    3 পৃষ্ঠাREST-CVL

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    25 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১০ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    21 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    21 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    19 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.40

    ১১ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    26 পৃষ্ঠা2.24B

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.34B

    ০৯ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    29 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    1 পৃষ্ঠা2.23B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    49 পৃষ্ঠা2.17B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    চার্জ নিবন্ধন 031470340009

    10 পৃষ্ঠাMR01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ ফেব, ২০১৩

    ২৬ ফেব, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,800,002
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    TRIGON SNACKS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PENDLETON, William John
    Bleasdale Close
    Aughton
    L39 6RU Ormskirk
    4
    Lancashire
    সচিব
    Bleasdale Close
    Aughton
    L39 6RU Ormskirk
    4
    Lancashire
    British16910480001
    CARDY, Brian Richard
    Murrell Cottage
    Murrell Hill Lane
    RG42 4DA Binfield
    Berkshire
    পরিচালক
    Murrell Cottage
    Murrell Hill Lane
    RG42 4DA Binfield
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive72003590001
    MILLINGTON, Richard John
    17 Buckden Court
    Silsden
    BD20 9LY Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Buckden Court
    Silsden
    BD20 9LY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director96446680001
    PENDLETON, William John
    Bleasdale Close
    Aughton
    L39 6RU Ormskirk
    4
    Lancashire
    পরিচালক
    Bleasdale Close
    Aughton
    L39 6RU Ormskirk
    4
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director16910480001
    BURKE, John
    45 Twiss Green Lane
    Culcheth
    WA3 4DQ Warrington
    সচিব
    45 Twiss Green Lane
    Culcheth
    WA3 4DQ Warrington
    British49130290003
    THORNLEY, Richard William
    Beech Cottage Oakmere Avenue
    Withnell
    PR6 8AX Chorley
    Lancashire
    সচিব
    Beech Cottage Oakmere Avenue
    Withnell
    PR6 8AX Chorley
    Lancashire
    BritishChartered Accountant10562330001
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    কর্পোরেট সচিব
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BURKE, John
    45 Twiss Green Lane
    Culcheth
    WA3 4DQ Warrington
    পরিচালক
    45 Twiss Green Lane
    Culcheth
    WA3 4DQ Warrington
    BritishFinance Dirctor49130290003
    COMBE, Michael
    6 Fairways Avenue
    FK2 0NY Maddiston
    Stirlingshire
    পরিচালক
    6 Fairways Avenue
    FK2 0NY Maddiston
    Stirlingshire
    BritishProduction Director100759430001
    DUGUID, Moray Stuart
    103 Highgate West Hill
    N6 6AP London
    পরিচালক
    103 Highgate West Hill
    N6 6AP London
    BritishCompany Director66137830002
    HAMER, Keith William
    4 Durrell Road
    SW6 5LH London
    পরিচালক
    4 Durrell Road
    SW6 5LH London
    United KingdomBritishInvestment Banker17259780001
    HILL, Duncan William
    Walton Head
    Walton Avenue, Pannal
    HG3 1EX Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Walton Head
    Walton Avenue, Pannal
    HG3 1EX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCommercial Director78432200001
    HOLLOWAY, Alan
    43 Countess Park
    L11 4UQ Liverpool
    Merseyside
    পরিচালক
    43 Countess Park
    L11 4UQ Liverpool
    Merseyside
    BritishProduction Director63621020001
    HOLLOWAY, Timothy Kevan
    Rectory Cottage
    Main Street Epperstone
    NG14 6AG Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Rectory Cottage
    Main Street Epperstone
    NG14 6AG Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishSales Director63620400001
    MCGHEE, Andrew Raymond
    Hillcrest 10 Meadowfield Road
    NE43 7QX Stocksfield
    Northumberland
    পরিচালক
    Hillcrest 10 Meadowfield Road
    NE43 7QX Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director4659270001
    MILLINGTON, Richard John
    17 Buckden Court
    Silsden
    BD20 9LY Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Buckden Court
    Silsden
    BD20 9LY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales96446680001
    SAUL, Lynn
    High View
    Syke Road Burnopfield
    NE16 6AU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    High View
    Syke Road Burnopfield
    NE16 6AU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishTechnical Director63620600001
    SYKES, John Keith
    Knowles Hill Road
    TQ12 2PR Newton Abbot
    50
    Devon
    পরিচালক
    Knowles Hill Road
    TQ12 2PR Newton Abbot
    50
    Devon
    BritishCompany Director5432520001
    THOMPSON, John Alan
    6 Oak Meadows Court
    Rainhill
    L35 6QD Prescot
    Merseyside
    পরিচালক
    6 Oak Meadows Court
    Rainhill
    L35 6QD Prescot
    Merseyside
    EnglandBritishSupply Chain Director60966890001
    WHITTLE, Raymond Brian
    Chestnut Lodge
    Woodland Rise
    HU14 3JT Woodgates Lane North Ferriby
    N Humberside
    পরিচালক
    Chestnut Lodge
    Woodland Rise
    HU14 3JT Woodgates Lane North Ferriby
    N Humberside
    BritishManaging Director74244300002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    TRIGON SNACKS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০১৩
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land on the north side of atherton road liverpool t/no MS386985. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north side of atherton road, fazakerley t/no MS316682; by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Items which are the subject of invoice number 5887 which is dated 31 january invoice number 5967 which is dated 30 march 2007 and invoice number 5973 which is dated 3 april 2007 in each case issured from peco controls - europe limited to the company. For further details of chattels charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All freehold and leasehold property of the company,all other vestates and interests in land,the goodwill,uncalled capital,all intellectual property rights,chattels,receivables,shares or loan capital,benefit of all licences,consents; floating charge over all undertaking,property and assets whatsoever.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vreedenlust Fund Ii B.V.,Brasland B.V,Plantation U.a,Brian Cardy and Duncan Hill
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 7 october 1988
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £38,198.50.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land and premises situate on the north side of atherton road and the east side of wareing road fazakerley county of liverpool t/no MS16682 with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    TRIGON SNACKS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১০ সেপ, ২০১৩প্রশাসন শুরু
    ১১ জুন, ২০১৪প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    অভ্যাসকারী
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৪ ডিসে, ২০২০ভেঙে গেছে
    ১১ জুন, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    প্রস্তাবিত তরলকারী
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    প্রস্তাবিত তরলকারী
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    অভ্যাসকারী
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0