BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03156768
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SLATERSHELFCO 312 LIMITED০৮ ফেব, ১৯৯৬০৮ ফেব, ১৯৯৬

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৭ জুন, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT থেকে C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ ফেব, ২০১৬

    ০৯ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ ফেব, ২০১৫

    ১২ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ ফেব, ২০১৪

    ২০ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে Mr Kevin James Crotty-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kevin James Crotty-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Andrew Allan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Robert Yates এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Richard Malin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Iain Grant এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    সচিব
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    BritishCompany Director96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    সচিব
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    মনোনীত সচিব
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant80043450001
    DUNN, Christopher Frank
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    মনোনীত পরিচালক
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British900005180001
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    পরিচালক
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    পরিচালক
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant2582690002
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    পরিচালক
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker48153170001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    মনোনীত পরিচালক
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    পরিচালক
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor30535590006

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    B2000 borrower security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Automobile Association Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0