NORTHWORLD LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNORTHWORLD LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03160029
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NORTHWORLD LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5242) /
    • (5243) /

    NORTHWORLD LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    DELOITTE LLP
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NORTHWORLD LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৭ জানু, ২০০৭

    NORTHWORLD LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.72

    ১৯ মে, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ নভে, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ মে, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ নভে, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ মে, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রবণ কমিটির সংবিধানের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠা4.48

    ক্রেডিটর কমিটির গঠনের সংশোধিত শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠা2.26B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    13 পৃষ্ঠা2.34B

    ১৯ নভে, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    21 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটর কমিটির গঠনের সংশোধিত শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠা2.26B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    29 পৃষ্ঠা2.23B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.15B/2.14B

    11 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    28 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Amend & restate agree 22/01/08
    RES13

    NORTHWORLD LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    কর্পোরেট সচিব
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    MCGOWAN, Paul Patrick
    372 Queenstown Road
    SW8 4NT London
    60 Eustace Building
    পরিচালক
    372 Queenstown Road
    SW8 4NT London
    60 Eustace Building
    EnglandIrish132951490001
    BRUNNING, Nigel Peter
    21 Trinity Road
    SS6 8QD Rayleigh
    Essex
    সচিব
    21 Trinity Road
    SS6 8QD Rayleigh
    Essex
    British106132520001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত সচিব
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    British30306840002
    MCPHERSON, Elaine
    9 Richmond Green
    Richmond Road Bowdon
    WA14 2UB Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    9 Richmond Green
    Richmond Road Bowdon
    WA14 2UB Altrincham
    Cheshire
    British56809580001
    THOMPSON, David Alan
    Blythe Hall
    Blythe Lane
    L40 5TY Lathom
    Lancashire
    সচিব
    Blythe Hall
    Blythe Lane
    L40 5TY Lathom
    Lancashire
    British6462070002
    VOGEL, David Norman
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    সচিব
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    British48520460001
    BRUNNING, Nigel Peter
    21 Trinity Road
    SS6 8QD Rayleigh
    Essex
    পরিচালক
    21 Trinity Road
    SS6 8QD Rayleigh
    Essex
    EnglandBritish106132520001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    মনোনীত পরিচালক
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GALVIN, Patrick Dominic
    7 Anglesea Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin
    D4
    Ireland
    পরিচালক
    7 Anglesea Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin
    D4
    Ireland
    Irish115314290001
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    পরিচালক
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    United KingdomBritish103945640001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    JOHNSTON, Leslie Matthew
    4 Kingsley Close
    Hampstead Gardens Suburb
    N2 0ES London
    পরিচালক
    4 Kingsley Close
    Hampstead Gardens Suburb
    N2 0ES London
    British109836170001
    LYON, Kevin John
    4 Burnside Road
    G46 6TT Glasgow
    পরিচালক
    4 Burnside Road
    G46 6TT Glasgow
    ScotlandBritish114851270001
    MCPHERSON, Elaine
    Avalon
    41a South Downs Road Bowdon
    WA14 3HD Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    Avalon
    41a South Downs Road Bowdon
    WA14 3HD Altrincham
    Cheshire
    British56809580002
    RAHAMIM, Michael Minashi
    135 Hamilton Terrace
    NW8 9QR London
    পরিচালক
    135 Hamilton Terrace
    NW8 9QR London
    EnglandBritish10291180001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    পরিচালক
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    SZIRTES, Andras
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    পরিচালক
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    United KingdomHungarian117998660001
    THOMPSON, David Alan
    Blythe Hall
    Blythe Lane
    L40 5TY Lathom
    Lancashire
    পরিচালক
    Blythe Hall
    Blythe Lane
    L40 5TY Lathom
    Lancashire
    British6462070002

    NORTHWORLD LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Philip Nigel Ross Green (The Initial Noteholder)
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    12-18 (even) charlotte street portsmouth hampshire t/n HP273647, 2-8 queen street swan square burslem stoke on trent staffordshire t/n SF279618 and 72/74 newgate street bishop auckland county durham t/n DU14875 and DU152228.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First party charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of the account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage f/h-72-74 newgate street bishop auckland durham and the proceeds of sale thereof; by way of floating security over all property and assets of whatsoever nature now or in the future owned or acquired by the company.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage f/h-2-8 queen street burslem stoke-on-trent and the proceeds of sale thereof; by way of floating security all property and assets of whatsoever nature now or in the future owned or acquired by the company.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company charges the property comprised in the deed policies securities certificates and/or other documents which have been or may from time to time be deposited with the bank as a continuing security.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent security deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 3/6/93
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £12 ,750 together with any interest credited to the deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Badrudin Ali Mohamed Haji-Omar
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deeds policies securities certificates and/or other documents which have been or may from time to time be deposited with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a sub-lease dated 10TH october 1988
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The tenant's interest in the deposit account relating to unit 4 (no 26) hounds hill centre,blackpool.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Pearl Assurance Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 12-18 (even) charlotte street portsmouth. By way of floating security over all property and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date and/or the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sale assets comprised in an agreement dated 20/1/97 (as defined) over the properties listed together with the equipment,stock,vehicles,fixtures/fittings,the debts,goodwill of business,records,issued share capital of xceptions stores LTD,all policies of insurance and all other assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Philip N.R.Green
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৯৭অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৯৩
    অর্জিত হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Tha sale assets comprised in an agreement dated 20/1/97 (as defined) with all equipment,stock,the vehicles,fixtures/fittings,the debts,the goodwill and records; the benefit of all insurance policies relating to the properties listed and all other assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank Leumi (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৯৭অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    NORTHWORLD LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ মে, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    ২০ মে, ২০০৯প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche
    P O Box 810
    Stonecutter Court
    1 Stonecutter Street London Ec4a 4tr
    অভ্যাসকারী
    Deloitte & Touche
    P O Box 810
    Stonecutter Court
    1 Stonecutter Street London Ec4a 4tr
    Lee Antony Manning
    1 Stonecutter Street
    London
    Ec4a 4tr
    অভ্যাসকারী
    1 Stonecutter Street
    London
    Ec4a 4tr
    2
    তারিখপ্রকার
    ২০ মে, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৩ নভে, ২০১২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    অভ্যাসকারী
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Lee Antony Manning
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London
    অভ্যাসকারী
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0