L P GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামL P GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03162838
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    L P GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    L P GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    L P GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HAWKSPARK LIMITED২২ ফেব, ১৯৯৬২২ ফেব, ১৯৯৬

    L P GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০২

    L P GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০১ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(2)

    ০৮ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(2)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ঋণদাতাদের প্রতিবেদনের পর প্রশাসনিক রিসিভারশিপে বিবৃতির বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা3.3

    প্রশাসনিক রিসিভারের প্রতিবেদন

    6 পৃষ্ঠা3.10

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(1)

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed lister-petter group LIMITED\certificate issued on 18/03/04
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০১ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা88(2)R

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Restructure co loan 27/09/01
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11

    L P GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SARGENT, Larry Terence
    Lime Tree House
    Kingston Road, Shalbourne
    SN8 3QD Marlborough
    Wiltshire
    সচিব
    Lime Tree House
    Kingston Road, Shalbourne
    SN8 3QD Marlborough
    Wiltshire
    BritishFinance Director14750950002
    CLARKE, Gareth John
    19 Gellideg Heights
    Maesycwmmer
    CF8 7RL Hengoed
    Mid Glamorgan
    সচিব
    19 Gellideg Heights
    Maesycwmmer
    CF8 7RL Hengoed
    Mid Glamorgan
    BritishAccountant11933570001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BRAND, Malcolm Arthur
    Upton House
    Pershore Road, Upton Snodsbury
    WR7 4NR Worcester
    Worcestershire
    পরিচালক
    Upton House
    Pershore Road, Upton Snodsbury
    WR7 4NR Worcester
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant34136260011
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    মনোনীত পরিচালক
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLARKE, Gareth John
    19 Gellideg Heights
    Maesycwmmer
    CF8 7RL Hengoed
    Mid Glamorgan
    পরিচালক
    19 Gellideg Heights
    Maesycwmmer
    CF8 7RL Hengoed
    Mid Glamorgan
    BritishAccountant11933570001
    DEAN, Bonnie Phillips
    13 Brock Street
    BA1 2LW Bath
    Avon
    পরিচালক
    13 Brock Street
    BA1 2LW Bath
    Avon
    EnglandUnited KingdomChief Executive Officer50903700003
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    মনোনীত পরিচালক
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SARGENT, Larry Terence
    Lime Tree House
    Kingston Road, Shalbourne
    SN8 3QD Marlborough
    Wiltshire
    পরিচালক
    Lime Tree House
    Kingston Road, Shalbourne
    SN8 3QD Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director14750950002
    SHARPE, Randolph Terence
    Holcombe Glen Cottage
    Minchinhampton
    GL6 9AJ Stroud
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Holcombe Glen Cottage
    Minchinhampton
    GL6 9AJ Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritishProduction Engineer55057990001
    TEMPEST, Philip Anthony
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    পরিচালক
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director36898820002
    WINCKLES, Richard
    Moor House
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Moor House
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    BritishVenture Capitailist66498580001
    WRIGHT, Phillip
    81 Vicerow Court Prince Albert Road
    NW8 7PP London
    পরিচালক
    81 Vicerow Court Prince Albert Road
    NW8 7PP London
    BritishBusinessman62546260002
    WRIGLEY, Graham Lloyd
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    পরিচালক
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    BritishVenture Capitalist42659840001

    L P GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of counter-indemnity and charge over credit balances dated 1ST december 2000
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 2 (counter-indemnity) of the deed (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee, by way of fixed charge the deposit, together with all interest from time to time accruing on such deposit, the assigned to the bank for the purposes of and to give effect to the security created by the deed its right to require the bank to repay to it the deposit and to pay interest on such deposit to it. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at dursley,gloucestershire; t/no gr 187515;all buildings,fixtures,fixed plant/machinery thereon and all moneys and liabilities to be paid or discharged. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental charge of copyright
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All copyrights and design rights owned by the chargor in and in relation to the works listed. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Patent charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the patents and all the chargor's rights in respect of the inventions in respect of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental charge of trade marks, trade names and goodwill
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee and debenture of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All registered trade marks and trade mark applications which belong to the chargor now or in the future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "security documents" (as defined in the guarantee and debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandf the Beneficiaries)(In Its Capacity as Security Trustee on Behalf O
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ২০০৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • ১৬ জুল, ২০০৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • ০৭ জুন, ২০০৬একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (405 (2))
      • মামলা নম্বর 1
    Stock pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee now or hereafter existing under the loan documents (as defined) and all obligations now or hereafter existing under the agreement or any other agreement between the company and any of the secured parties (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Security Trustee on Behalfrties (As Defined)of the Finance Parties and the Hedging Counterpa
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    L P GROUP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৯ জুন, ১৯৯৬যন্ত্রের তারিখ
    প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark James Shaw
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    অভ্যাসকারী
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    Phillip Rodney Sykes
    Moore Stephens Corporate Recover
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London
    অভ্যাসকারী
    Moore Stephens Corporate Recover
    1 Snow Hill
    EC1A 2EN London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0