CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03167993
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRYGONE PROPERTIES LTD১৬ ডিসে, ২০০৫১৬ ডিসে, ২০০৫
    SMARTSENSE LIMITED০২ এপ্রি, ১৯৯৬০২ এপ্রি, ১৯৯৬
    SMARTSCENE LIMITED০৫ মার্চ, ১৯৯৬০৫ মার্চ, ১৯৯৬

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২৭ আগ, ২০২০ তারিখে Mr Gary Ryan Fee-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৬ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Rosamund Margaret Marshall-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Guy Casagrande-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Gary Ryan Fee-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Walter Tugendhat এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dave Lissy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Dreier এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৭ জানু, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ জানু, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ জানু, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 23 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ জানু, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ১০ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Walter Tugendhat-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ জানু, ২০১৬

    ২৭ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ ডিসে, ২০১৫

    ০৩ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mary Ann Tocio এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ এপ্রি, ২০১৫

    ০১ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    সচিব
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    170449670001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican70853820001
    CASAGRANDE, John Guy
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican269010340001
    FEE, Gary Ryan
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish269008830002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    EnglandBritish269043470001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    সচিব
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    সচিব
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    সচিব
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    British169843720001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    সচিব
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    BULL, Malcolm Richard
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    EnglandBritish10155680001
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    পরিচালক
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican170443250001
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LEWIS, David
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    পরিচালক
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    British51773710002
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican218331690001
    MALCOLMSON, John Bryce
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    পরিচালক
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    British51773690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    UsaUsa177507090001
    TUGENDHAT, James Walter
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish218306870001
    WHITLAM, Paul
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    পরিচালক
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    British47737380001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Bright Horizons Family Solutions Limited
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    ২৭ জানু, ২০১৭
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন, যেটি আইন অনুযায়ী একটি আইনগত ব্যক্তি নয়; এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ (তাদের এধারনের অধিকারবলে) কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £36,000=00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The cash sum of £36,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Classic Management Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H former garage premises grena road richmond surrey t/n TGL189133 and the security assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H inglewood farm sonning lane sonning t/no BK225651,f/h land adjoining inglewood house sonning lane sonning berkshire t/no BK309428 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture being supplemental to a debentured given on 21 december 2004 and
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Strathmore house brighton road banstead t/n SY381533, high trees wokingham road rounds hill bracknell t/n BK159196, 1 cob close tassel road bury st edmunds t/n's SK251153 and SK284737, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at academy day nursery gibson drive kings hill west malling (t/no K824499) see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property owned by the mortgagor k/a merrow clinic 19 boxgrove lane merrow guildford t/no SY259691. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Securitytrustee)
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at stepping stones 105 penn hill avenue poole dorset t/no DT47303 and f/h property k/a moonacre potterne way verwood dorset t/no DT67285. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H shortlands united reform church 84-90 martins road bromley t/no SGL584373, f/h 48 sydenham road croydon t/no SGL615676 and f/h 83A belmont hill lewisham london t/no SGL193573.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1) f/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, t/n SY105671, 2) f/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, t/n HP559226, 3) f/h property k/a hatton hill nursery, hatton hill, windlesham, surrey, t/n SY420855 and SY565088, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Accession deed to intercreditor deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ আগ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property known as nursery school site, rail road heath, fleet, hert, hampshire t/n HP613289. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold property known as farnborough day nursery formerly rushmore independent school 40 reading road farnborough rushmore hampshire title number HP559226. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that leasehold property known as land and premises situate at and known as the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold property known as hatton hill day nursery being the land and buildings on the south side of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY420855 and all that freehold land laying to the south west of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY565088. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold property known as frimley green day nursery 1 the green frimley green surrey heath surrey GU16 6HF title number SY105671. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £310,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold property k/a land at elvetham heath fleet hampshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £295,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 the green frimley green camberley surrey.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a rushmoor independent school comprising piece of land having a frontage of 80 feet to the north side of reading road farnborough. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at 22 crawley hill canberley t/no;-SY166415.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sunley Ventures Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Mylesdown 22 crawley hill camberley street surrey t/n sy 166415.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the southside of hatton hill windlesham and land lying to the south west ofhatton hill widlesham surrey t/no SY420855 & sy 565088.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0