ST. JAMES'S PLACE PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামST. JAMES'S PLACE PLC
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03183415
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    ST. JAMES'S PLACE PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    Gloucestershire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ST. JAMES'S PLACE CAPITAL PLC১৬ আগ, ১৯৯৬১৬ আগ, ১৯৯৬

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৪

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ জুন, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৭ জুন, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ জুন, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ৩১ ডিসে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Rosemary Hilary এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ ডিসে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,066,820.25
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ১৭ ডিসে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,065,339
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ০৮ ডিসে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,063,426.5
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ২৮ নভে, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,061,589
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ১৪ অক্টো, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,055,926.50
    6 পৃষ্ঠাSH06

    ০৭ অক্টো, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,083,226.50
    6 পৃষ্ঠাSH06

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৫ নভে, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    legacy

    পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাRP01SH01

    ২৮ আগ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,893,457.65
    4 পৃষ্ঠাSH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৬ নভে, ২০২৫Replaced A replacement SH01 was registered 26/11/25 as the original contained an error

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৯ নভে, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    ৩০ সেপ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 79,228,126.50
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৭ নভে, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    ১৯ আগ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 80,040,735.90
    6 পৃষ্ঠাSH06

    ২৩ সেপ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বাতিল। মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 9,368,436.50
    6 পৃষ্ঠাSH06

    নিজস্ব শেয়ার ক্রয়।

    4 পৃষ্ঠাSH03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৩ নভে, ২০২৫Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    ST. JAMES'S PLACE PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DALE, Jonathan
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    সচিব
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    285453520001
    ANAND, Rooney
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    EnglandBritish330778240001
    BECK, Helen Claire
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish337547470001
    FITZPATRICK, Mark Thomas
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    EnglandIrish314262460001
    FRASER, Simon William David
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish96378620001
    HITCHINS, John Charles Fortescue
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place Plc
    Glos
    United Kingdom
    পরিচালক
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place Plc
    Glos
    United Kingdom
    EnglandBritish289434560001
    JAMES, Penelope Jane
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish337547440001
    MANDUCA, Paul Victor Falzon Sant
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish,Maltese7212170004
    WADDINGTON, Caroline Mary
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish75652080005
    ARMITAGE, Matthew
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    সচিব
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    British98110790002
    FRASER, Kay Lisa
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    সচিব
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    181478470001
    GLADMAN, Hugh John
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    সচিব
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    British41485310006
    KELLY, Elizabeth Janet
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    সচিব
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    199677510001
    LANGFIELD, Andrea Valerie
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    সচিব
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    British52526910001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    সচিব
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    British158167450001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    সচিব
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    British117273030002
    SANDERS, Stephen Robin
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    সচিব
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    British38839120001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BAILEY, Charles Howard
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    পরিচালক
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritish1992450001
    BATES, Sarah Catherine
    12 Alwyne Place
    N1 2NL London
    পরিচালক
    12 Alwyne Place
    N1 2NL London
    United KingdomBritish65874310002
    BAZALGETTE, Vivian Paul
    Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish69074010001
    BELLAMY, David Charles
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish84428640001
    BRADSHAW, Paul Richard
    5 South End Close
    Hursley
    SO21 2LJ Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    5 South End Close
    Hursley
    SO21 2LJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish47181430001
    BURKE, Dominic James
    GL7 1FP Cirencester, Gloucestershire
    St. James's Place House, 1 Tetbury Road
    United Kingdom
    পরিচালক
    GL7 1FP Cirencester, Gloucestershire
    St. James's Place House, 1 Tetbury Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish256291010003
    COLSELL, Steven James
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    পরিচালক
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    EnglandBritish101387770001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    CORNISH, Iain Charles Andrew
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Glos
    United Kingdom
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritish66522190006
    CROFT, Andrew Martin
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish55940940004
    CROSBY, James Robert, Sir
    Glendevon House
    Howhill Road, Beckwithshaw
    HG3 1QJ Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Glendevon House
    Howhill Road, Beckwithshaw
    HG3 1QJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandUk18867860005
    DAWSON, Joanne
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    পরিচালক
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    British112053530004
    D`URSO, Mario
    Viale Di Villa
    Grazioli 4/A
    00198 Rome
    Italy
    পরিচালক
    Viale Di Villa
    Grazioli 4/A
    00198 Rome
    Italy
    Italian57386290001
    EDWARDS, John Stephen
    Ebbor House
    Wookey Hole
    BA5 1AY Wells
    Somerset
    পরিচালক
    Ebbor House
    Wookey Hole
    BA5 1AY Wells
    Somerset
    British143155400001
    GASCOIGNE, Ian Stewart
    Tennis Drive
    The Park
    NG7 1AE Nottingham
    19
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tennis Drive
    The Park
    NG7 1AE Nottingham
    19
    United Kingdom
    United KingdomBritish54370650002
    GENTLE, Craig Gordon
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    EnglandBritish241604310001
    GREGSON, Charles Henry
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Gloucestershire
    পরিচালক
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Gloucestershire
    United KingdomBritish145678020001

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0