DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03189091
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BREAKTODAY LIMITED২২ এপ্রি, ১৯৯৬২২ এপ্রি, ১৯৯৬

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ মে, ২০১৫

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ জুন, ২০১৬

    ০৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 103,630
    SH01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মে, ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Frederick Cooper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martyn Taylor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Maurie Martin Byrne-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Geoffrey Brendon Wilding-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Joseph Snee-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    চার্জ নিবন্ধন 031890910010, ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    13 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ৩০ মে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Reeder এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ মে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Frederick Cooper-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ মে, ২০১৫

    ১১ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 103,630
    SH01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    19 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    চার্জ নিবন্ধন 031890910009, ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    68 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ এপ্রি, ২০১৪

    ২৪ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 103,630
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ০১ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NOROSE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    কর্পোরেট সচিব
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    70621550002
    BYRNE, Stephen Maurie Martin
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishCarpet Merchant201392200001
    SNEE, John Joseph
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishTextile Manager56387920003
    WILDING, Geoffrey Brendon
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Worcester Road
    DY10 1JR Kidderminster
    Victoria Carpets Ltd
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector156337740001
    CARTER, David Joseph
    Andorra 8 Stiles Avenue
    Marple
    SK6 6LR Stockport
    Cheshire
    সচিব
    Andorra 8 Stiles Avenue
    Marple
    SK6 6LR Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director14466960001
    CARTER, Neil Alexander
    8 Lonsdale Avenue
    Hutton
    CM13 1NH Brentwood
    Essex
    সচিব
    8 Lonsdale Avenue
    Hutton
    CM13 1NH Brentwood
    Essex
    BritishTrainee Solicitor47762770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CARDINI, Filippo John
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    পরিচালক
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    BritishSolicitor56314170001
    CARTER, David Joseph
    Andorra 8 Stiles Avenue
    Marple
    SK6 6LR Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Andorra 8 Stiles Avenue
    Marple
    SK6 6LR Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director14466960001
    CARTER, Neil Alexander
    8 Lonsdale Avenue
    Hutton
    CM13 1NH Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    8 Lonsdale Avenue
    Hutton
    CM13 1NH Brentwood
    Essex
    BritishTrainee Solicitor47762770001
    COOPER, John Frederick
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishNone198787460001
    DAVISON, Guy Bryce
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    পরিচালক
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    BritishInvestment Director48717030002
    DOWNES, Paul William Edwin
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector18135910002
    DOWNEY, Stephen David
    Chandlers Cottage
    Flawith
    YO61 1SF Alne
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Chandlers Cottage
    Flawith
    YO61 1SF Alne
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector152018290001
    DUNN, Larry
    4 Redshank Drive
    The Fairways Tytherington
    SK10 2SN Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    4 Redshank Drive
    The Fairways Tytherington
    SK10 2SN Macclesfield
    Cheshire
    AmericanDirector56752970004
    HARRISON, Geoffrey
    40 The Majestic
    North Promenade
    FY8 2NE St Annes On Sea
    Lancashire
    পরিচালক
    40 The Majestic
    North Promenade
    FY8 2NE St Annes On Sea
    Lancashire
    BritishCompany Director59039160001
    JERVIS, Noel
    Spencer House
    Spencer Drive Nuthall
    NG16 1DQ Nottingham
    পরিচালক
    Spencer House
    Spencer Drive Nuthall
    NG16 1DQ Nottingham
    United KingdomBritishCompany Director78237180002
    MROZEK, Bernard
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishTechnical Director48123910001
    REEDER, Philip
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector65969990003
    RINNER, Erick Robert Maurice
    21 Warriner Gardens
    SW11 4EA London
    পরিচালক
    21 Warriner Gardens
    SW11 4EA London
    United KingdomFrenchDirector73146550002
    TAYLOR, Martyn
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Broadway
    Haslingden
    BB4 4LS Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director49551600002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    DURALAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০১৫
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ২০১৫
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north east side of knowsley road haslingden rossendale lancashire t/no LA913212. Please see image for details of further property charged.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Charge over bank account
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in the security account numbered 13200 001 and the account balance,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kaupthing Bank H.F.
    ব্যবসায়
    • ০৬ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to each secured lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the shares of stock all cash securities and dividends all additional shares of stock all products and proceeds of all the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kaupthing Bank Hk as Security Trustee for Itself and Each Secured Lender
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kaupthing Bank Hf as Security Trustee for the Secured Parties 'Security Trustee'
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee and security interest agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company including the company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company to the intent that the security trustee shall have a first security interest in the securities and the distribution rights: 1. grants possession of the certificates of title to the securities to the security trustee and vests possession of the certificates of title to the securities in the security trustee; and 2. assigns, transfers and otherwise makes over to the security trustee its right, title and interest in and to the distribution rights.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or the other obligors to the chargee and the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares of the capital stock of duralay usa, inc., A delaware corporation ("U.S. subsidiary") and the certificates representing the shares of such capital stock, all options and warrants for the purchase of shares of the capital stock of the U.S. subsidiary now or hereafter held by the pledgor (the pledged stock) and all dividends, cash, instruments and other property from time to time received, receivable or otherwise distributed in respect of, or in exchange for, any or all of the pledged stock. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or any other company within the group (as defined) to the chargee under or pursuant to, the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (A) by way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property as at the date of the debenture or at any time during the continuance of the secuirty created by the debenture belonging to the company and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures from time to time on any such property belonging to the charged company;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Keyman insurance assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company assigned absolutely with full title guarantee all its rights, benefit and title in and to the policy and the proceeds set out in the schedule on the form 395 (the "policy"), and the full benefit thereof as a continuing security to the security trustee as agent and trustee for the secured parties.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0