RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামRENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03200097
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Wey Court West
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Surrey
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SOUTHERN LAND DEVELOPMENTS LIMITED১৭ মে, ১৯৯৬১৭ মে, ১৯৯৬

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১৭ থেকে ৩০ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জুন, ২০১৬

    ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ জুন, ২০১৫

    ১২ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6
    SH01

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ জুল, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Paul Anthony Watkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১৫ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Anthony Watkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ জুল, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Towngate House 2-8 Parkstone Road Poole Dorset BH15 2PW থেকে Wey Court West Union Road Farnham Surrey GU9 7PTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ জুন, ২০১৪

    ২৩ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    দ্বিতীয় দায়ের AR01 এর যা পূর্বে কোম্পানিজ হাউসে জমা দেওয়া হয়েছিল ১৭ মে, ২০১২ তারিখে

    16 পৃষ্ঠাRP04

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ

    3 পৃষ্ঠাSH10

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    ২০ জুন, ২০১২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6
    4 পৃষ্ঠাSH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    6 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TAYLOR, Robert Mark
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    পরিচালক
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    EnglandBritish46522020003
    TAYLOR, Helen
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    সচিব
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    British89688100002
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    সচিব
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870003
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BELL, Matthew Robin
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    পরিচালক
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    British99628170002
    HILL, Richard James Barclay
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    পরিচালক
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish41718540001
    KEEYS, William Albert
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    পরিচালক
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    EnglandBritish99628190001
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    পরিচালক
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870004
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষThe Companies Act
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03404258
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 25% এর বেশি কিন্তু 50% এর বেশি নয়, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land at manor farm site, dorchester road, frampton dorset by way of first fixed charge all the machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishings equipment tools and other chattels, the rental income, by way of floating charge all the undertaking and all property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a tor sands hotel 8 sands road paignton title absolute t/n DN83974 together with all buildings fixtures and erections thereon; fixed charge all monies received under any policy of insurance,the goodwill of any business and any share held in any management company.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal charge the property k/a southlands, northfield road, minehead, t/n ST149054, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal charge the property k/a rectory house hotel and adjoining land, northfield road, minehead, somerset, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Coram court and land on the west side of coram court sidmouth road lyme regis t/no;-DT276150 DT274706 all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings and equipment all goodwill rental income present and future and floating charge over undertaking and all property and assets not charged by way of fixed charge above.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Second legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £225,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset t/nos: DT276150 and DT274706 subject to a first charge dated 28TH august 2001 in favour of close brothers limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John William Stenson and Judith Elizabeth Stenson
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J and J Stenson Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots A1-A4 phase 1 section a pandbury bridport road dorchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the company's benefit, right, title and interest under arising out of or vested in the company pursuant to the development agreement of even date. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0