POWERMARQUE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPOWERMARQUE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03204406
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    POWERMARQUE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5010) /
    • (5020) /

    POWERMARQUE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    POWERMARQUE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEVRUS (680) LIMITED২৮ মে, ১৯৯৬২৮ মে, ১৯৯৬

    POWERMARQUE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৪

    POWERMARQUE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    পুনঃ নিবন্ধনের রেজুলেশন

    RES02

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা652a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    পৃষ্ঠা363(288)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    7 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    POWERMARQUE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    সচিব
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    English94987030001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    সচিব
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish94987030001
    VENSON GROUP PLC
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    119183190001
    VENSON HOLDINGS LIMITED
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    116764790001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    সচিব
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    সচিব
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    LAW, Stuart Peter
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    মনোনীত সচিব
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    British900005090001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    সচিব
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    পরিচালক
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    পরিচালক
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    DALY, James
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62710230001
    DICKINSON, Roger Martin
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    পরিচালক
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    British91579530001
    DOONEY, Michael Martin
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    পরিচালক
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Irish68419160001
    DUNNE, Matthew
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British80391440001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    পরিচালক
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    পরিচালক
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GIBBONS, David Victor
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    মনোনীত পরিচালক
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    British900005080001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    পরিচালক
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    MELLOR, Christopher John
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    পরিচালক
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    United KingdomUk97680390001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    SCRIVEN, Grant John Paul
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    পরিচালক
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    United KingdomIrish28260840002
    WATSON, Charles Dishington
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish41054110001
    WILLIAMSON, Alister Wallace
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    British29612530001

    POWERMARQUE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Account charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the deposit and all the entitlements to interest the rights to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capital Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the goods, vehicles and equipment details of which are set our in the sale afgreement, together with the operating instructions, handbooks, specifications and books pertaining thereto and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fortis Lease UK Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right, title, benefit and interest, present and future, under or arising out of or in respect of the relevant agreements; in, to and in respect of the vehicles the subject of the relevant agreements; in, to and in respect of all and any proceeds of claims made under the insurance in respect of the vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fortis Lease UK Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0