OHI BEAUMONT PARK LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOHI BEAUMONT PARK LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03213741
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • আবাসিক নার্সিং কেয়ার সুবিধা (87100) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম

    OHI BEAUMONT PARK LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Tower 42 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BEAUMONT PARK LIMITED২২ মে, ২০০২২২ মে, ২০০২
    PINELAKE CARE LIMITED১৮ জুন, ১৯৯৬১৮ জুন, ১৯৯৬

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ১৮ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    35 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ২৭ সেপ, ২০১৭ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১৮ জুন, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd এর বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাPSC02

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে Daniel J Booth-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে Mr Robert Stephenson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে Mr Michael Ritz-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে Mr Daniel Booth-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৮ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Citypoint Level 33 1 Ropemaker Street London EC2Y 9UE England থেকে Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    32 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    second-filing-of-annual-return-with-made-up-date

    23 পৃষ্ঠাRP04AR01

    second-filing-of-annual-return-with-made-up-date

    23 পৃষ্ঠাRP04AR01

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BOOTH, Daniel J
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    সচিব
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    197726300001
    BOOTH, Daniel James
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    পরিচালক
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican265749890001
    RITZ, Michael Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    পরিচালক
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican231342520001
    STEPHENSON, Robert
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    পরিচালক
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican196594350001
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    সচিব
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    British82185990001
    BOGGON, Deirdre Irene
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    সচিব
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    British51553190001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    সচিব
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    British7897560001
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    সচিব
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    British96916290001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BATES, David John
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish96384800003
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    পরিচালক
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    EnglandBritish82185990001
    CHRISTIAN, Deborah Helen
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish187897170001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    পরিচালক
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    EnglandBritish7897560002
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish147828420021
    ROGERS, Pamela Anne
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    পরিচালক
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    British63140670001
    STOTT, Yvette Ann
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    পরিচালক
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    British56606030001
    WARD, Gordon Robert
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    পরিচালক
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    British48287480003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর03995046
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    OHI BEAUMONT PARK LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk SK275266; the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk NK338434; fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk SK145383 (for further details of properties charged please refer to form 395) and/or its proceeds of sale. Floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk t/no SK275266 the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk t/no NK338434 fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk t/no SK145383 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage over all that freehold property known as west of shortmead street biggleswade and freehold property on the west side of shortmead street biggleswade. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The land and buildings on the west side of shortmead st biggleswade known as beaumont park shortmead st biggleswade t/no BD123120 BD127708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge over chattels
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee by way of first fixed charge: 1)the fixed assets together with any and all assets subsequently acquired by the company by way of replacement thereof 2)items of real or personal property tangible or intangible . fixed assets: 37 beds 37 wardrobes 37 chairs. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a land and premises at shotmead street, biggleswade bedford t/n's BD123120 and BD127708 assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0