ELECTRONIQUE GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামELECTRONIQUE GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03214376
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o C/O ROBNOR RESINS LIMITED
    31 Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RAVENGOLD LIMITED১৯ জুন, ১৯৯৬১৯ জুন, ১৯৯৬

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE থেকে C/O C/O Robnor Resins Limited 31 Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৬ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Crawford Wilson Gillan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ ফেব, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Crawford Wilson Gillan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ জানু, ২০১৫

    ১৯ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ জানু, ২০১৪

    ১৭ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    সচিব হিসাবে Frederick Hawley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr Crawford Wilson Gillan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mr Crawford Wilson Gillan-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Mr John Rae Henderson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Frederick Hawley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Gilles Coulombeau এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    পৃষ্ঠাANNOTATION

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Gilles Maire Jean Francois Coulombeau-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HENDERSON, John Rae
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    পরিচালক
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    ScotlandBritishDirector43301650001
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    সচিব
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    182622810001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director13540840002
    HARPER CORPORATION LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013980001
    COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    পরিচালক
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomFrenchCompany Director15117870004
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    পরিচালক
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    United KingdomBritishDirector182618510001
    HARDIE, Reginald George
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    BritishDirector422650001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director13540840002
    LING, Philip Henry
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    পরিচালক
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector2326420001
    WALTON, Michael Edward D'Arcy
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    পরিচালক
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    EnglandBritishCompany Director34866270001
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    65,002 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of electronique limited and all stocks securities and other property charged under the terms of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুল, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a units 2A and 2B hulme hall lane manchester t/n GM413956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a unit b harwood road littlehampton t/n WSX54330. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a unit a harwood road littlehampton t/n WSX50703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a land on the west side of byrom street liverpool t/n MS125497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a unit 2 harwood road littlehampton t/n WSX79974. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 42-48 fentenoy street liverpool t/n MS124039. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For property details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignation of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The life assurance policy dated 16 february 1996 issuedby crowe life on tthe life of colin douglas murray for the amount of £100,000 contract no. 733/Rml 16762 certificate number sed 1289 and all sums assured thereby and bonuses and benefits arising thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Crowe life assurance company policy no.sed 1221 dated 13.9.96 over the life of christopher james wilkins, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Crowe life assurance company policy no.sed 1217 dated 13.9.96 over the life of david smith, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Crowe life assurance company policy no.sed 1219 dated 13.9.96 over the life of giles marie coulombeau, sum assured:£500,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Crowe life assurance company policy no.sed 1218 dated 13.9.96 over the life of neil ancell, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Crowe life assurance company policy no.sed 1220 dated 13.9.96 over the life of fredrick william hawley, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage and charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lands and premises situate in the townland of killyhevlin parish of enniskillen barony of tirkennedy and county fermanagh .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মে, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৪ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0