OVERSON LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOVERSON LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিপ্রশাসন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03214899
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OVERSON LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9305) /

    OVERSON LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Recovery Hjs
    12 -14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OVERSON LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ জুন, ২০০৭
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ এপ্রি, ২০০৮
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৬

    OVERSON LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২১ জুন, ২০১৭
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০৫ জুল, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    OVERSON LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    OVERSON LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০৭ মে, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Charles Henry Pfister এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    5 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    6 পৃষ্ঠা2.23B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    annual-return২৯ জুন, ২০০৪

    legacy

    363(287)
    annual-return২৯ জুন, ২০০৪

    legacy

    363(288)

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    OVERSON LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    সচিব
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    মনোনীত সচিব
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    PFISTER, Charles Henry
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    সচিব
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    British67081640001
    BURGON, Mark Edward
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    পরিচালক
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritish100433200001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OVERSON LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land forming part of the garden of the property known as outerfield,tilford road,hindhead; part t/no sy 108357. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £60,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold land formerly part of the property outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mirafora Themistocli
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £75,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Carolyn Mary Popham
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £25,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Montagu Graeme Macdonald
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land adjoining courts mount road haslemere surrey.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • C.H. Pfister & R.J. Hager as Trustees of D M Hager Discretionary Settlement
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land adjoining courts mount barn courts mount road haslemere surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • R J Hager(As Trustees of the Mrs D M Hager 1997 Settlement)
    • C H Pfister
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert Michael Macdonald
    • Montagu Graeme Macdonald
    • Carolyn Mary Popham
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Donald Slough
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H part of the old bus depot midhurst west sussex. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of whole
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £25,000 due from the company to the chargee in accordance with the terms of the supplemental agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land lying to the north east of petworth rd,haslemere and garages; t/no sy 677075.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Carolyn Mary Popham
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of whole
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000 due or to become due from the company to the chargees
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land to the north of petworth road haslemere and garages surrey.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Carolyn Mary Popham and Robert Michael Macdonald
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land to the rear of 24 petworth road haslemere surrey t/n SY677075. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of whole
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargees
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings adjacent to greencroft scotland drive haslemere surreyt/no.SY248372.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Carolyn Mary Popham
    • Robert Michael Macdonald
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18TH august 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a the wheatsheaf grayswood roaf witley haslemere surrey t/n SY382663 and by way of floating charge the undertaking of the company and all it's property assets and rights present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Plt Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land adjacent to greencroft scotland drive haslemere surrey t/n-SY248372 by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 8TH july 1996 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed legal mortgage f/h property k/a the cottages verdley place furnhurst chichester west sussex first fixed charge all the company's right title and interest in any account from time to time opened and maintained by the company in accordance with the provisions of this charge and all monies (including interest thereon) standing from time to time to the credit of such account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Plt Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ১৯৯৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৫ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of whole
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £140,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    C1-C8 and GC1-GC5 verdley place fernhurst t/no wsx 195964.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mrs Dulcie Marguerite Hager
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ১৯৯৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৫ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    OVERSON LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ ফেব, ২০০৭প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Shane Biddlecombe
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0