PHIP CH LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPHIP CH LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03217536
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PHIP CH LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    PHIP CH LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PHIP CH LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED১১ মে, ২০০৪১১ মে, ২০০৪
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED১২ মে, ১৯৯৯১২ মে, ১৯৯৯
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED০১ মে, ১৯৯৮০১ মে, ১৯৯৮
    ANVIL LONDON LIMITED২৭ জুন, ১৯৯৬২৭ জুন, ১৯৯৬

    PHIP CH LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    PHIP CH LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Christopher Austin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy David Walker Arnott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard Howell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip John Holland এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    ০৮ জুল, ২০১৬ তারিখে Mr Philip John Holland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ জুল, ২০১৫

    ১০ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,333
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ জুল, ২০১৪

    ৩০ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,333
    SH01

    ০১ মে, ২০১৪ তারিখে Mr Timothy David Walker Arnott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ জুল, ২০১৪ তারিখে Mr Timothy David Walker Arnott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    সচিব হিসাবে Nexus Management Services Limited-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP04

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Margaret Vaughan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে J O Hambro Capital Management Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ জুল, ২০১৩

    ২২ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    PHIP CH LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    পরিচালক
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    পরিচালক
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    পরিচালক
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    সচিব
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    সচিব
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    সচিব
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    কর্পোরেট সচিব
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    পরিচালক
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    পরিচালক
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    পরিচালক
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    পরিচালক
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    পরিচালক
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    পরিচালক
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    পরিচালক
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    PHIP CH LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    ০১ জুন, ২০১৬
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    না
    আইনি ফর্মPublic Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর3033634
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    PHIP CH LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ এপ্রি, ২০০৮
    • ১৬ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0