VICKERS ELECTRONICS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVICKERS ELECTRONICS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03227029
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উত্পাদন (27900) / উৎপাদন

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HELPDEAN LIMITED১৯ জুল, ১৯৯৬১৯ জুল, ১৯৯৬

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জুল, ২০১৫

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    38 পৃষ্ঠাAM23

    ১৭ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Martin Blank এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    44 পৃষ্ঠাAM10

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    16 পৃষ্ঠাAM02

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    108 পৃষ্ঠাAM03

    ০৬ জুন, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Unit 14 Westpoint Enterprise Park Clarence Avenue Trafford Park Manchester M17 1QS থেকে C/O Duff & Phelps Ttd the Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EWপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    চার্জ 12 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ১৯ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ নিবন্ধন 032270290014, ০৮ জুন, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    34 পৃষ্ঠাMR01

    ১৩ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David James Hilton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alison Jacqueline Hilton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ নিবন্ধন 032270290013, ২৯ ফেব, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    38 পৃষ্ঠাMR01

    ২৮ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Raymond David Breckon-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুল, ২০১৫

    ২৯ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 177
    SH01

    ২৮ জুল, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Peter Andrew Turnbull-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২৮ জুল, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে David James Hilton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৫ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Richard Duncan Owen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ জুল, ২০১৪

    ২৩ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 177
    SH01

    ১৯ জুল, ২০১৪ তারিখে David James Hilton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৯ জুল, ২০১৪ তারিখে Alison Jacqueline Hilton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TURNBULL, Peter Andrew
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    সচিব
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    199769460001
    BRECKON, Raymond David
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    পরিচালক
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    EnglandBritishCompany Director70834670002
    THOMAS, Wayne
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    পরিচালক
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector161712760001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    সচিব
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    সচিব
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    BritishCompany Director107482670001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    সচিব
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    সচিব
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    British84738140001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    পরিচালক
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    BERRY, Keith
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    পরিচালক
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector60151490001
    BLANK, Stephen Martin
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    পরিচালক
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    United KingdomBritishDirector5733490001
    CAMERON, Ian Thomas
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    পরিচালক
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector156147320001
    HILTON, Alison Jacqueline
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    পরিচালক
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishSales Manager117736760003
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    পরিচালক
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    EnglandBritishCompany Director107482670005
    HILTON-TAPP, David
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    পরিচালক
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    BritishDirector67068110003
    HOYLE, John Roger Horrocks
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    পরিচালক
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    EnglandBritishCompany Director3986300001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    OWEN, Nicholas Richard Duncan
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    পরিচালক
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector1800950002
    THACKRAY, Adam Matthew
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    পরিচালক
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    United KingdomBritishOperations Manager117737630002
    THACKRAY, Simon
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    পরিচালক
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    EnglandBritishDirector67197060005
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    পরিচালক
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    EnglandBritishAccountant84738140001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Business Engagement Limited
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর05488174
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০১৬
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ২০১৬
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Evbl(General Partner Ev Sme Loans) Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of alison bagnall, policy no: L0195619092DQ with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of david hilton, policy no: L0198455092DX with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of simon thackray, policy no: 223890 with lutine assurance services limited in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal and general policy number 011443517-5 dated 4 july 2005 for the sum of £100,000 life assured david hilton together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lutine assurance services limited policy number 219871 dated 29 june 2005 for the sum of £200,000 life assured simon thackray together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its title right and interest in the policy. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mr David Russell
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    VICKERS ELECTRONICS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ এপ্রি, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ২২ মার্চ, ২০১৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0