ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03230015
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বাষ্প ও এয়ার কন্ডিশনিং সরবরাহ (35300) / বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং এয়ার কন্ডিশনিং সরবরাহ

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ABB ZANTINGH LIMITED২৬ অক্টো, ১৯৯৮২৬ অক্টো, ১৯৯৮
    ZANTINGH ENERGY SYSTEMS LIMITED ২৬ জুল, ১৯৯৬২৬ জুল, ১৯৯৬

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৮

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠাLIQ13

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    ২১ এপ্রি, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Daresbury Park Daresbury Warrington Cheshire WA4 4BT থেকে 30 Finsbury Square London EC2A 1AGপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Daresbury Park Daresbury Warrington Cheshire WA4 4BT এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২০ মার্চ, ২০২০ তারিখে

    LRESSP

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 1 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ০২ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David John Hughes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lena Maria Andersson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Grant Funnell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ২৬ জুল, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    legacy

    6 পৃষ্ঠাRP04CS01

    ২৫ আগ, ২০১৭ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণের দ্বিতীয় দাখিল

    • মূলধন: GBP 46,474,000.00
    7 পৃষ্ঠাRP04SH01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    legacy

    6 পৃষ্ঠাCS01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ৩০ জুল, ২০১৮Clarification A second filed CS01 (shareholder information change) was registered on 30/07/2018.
    ২৯ আগ, ২০১৮Clarification A second filed CS01 (statement of capital change and shareholder information change) was registered on 29/08/2018

    ২৫ আগ, ২০১৭ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000,000
    5 পৃষ্ঠাSH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৯ আগ, ২০১৮Clarification A SECOND FILED SH01 WAS REGISTERED ON 29/08/2018

    ২৬ জুল, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Trevor John Gregory এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MAC LEAN, Victoria Ann
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    সচিব
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    British185639340001
    HUGHES, David John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    পরিচালক
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishCountry Managing Director178402040001
    BAKEWELL, Robert Canvin
    2 The Fields
    Berrisford Road
    TF9 1JH Market Drayton
    Salop
    সচিব
    2 The Fields
    Berrisford Road
    TF9 1JH Market Drayton
    Salop
    British69223320001
    BENN, David
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    সচিব
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    British63042590001
    DICKENS, Nigel William
    Yewcourt Lodge Cobcroft Lane
    Cridling Stubbs
    WF11 0AZ Knottingley
    West Yorkshire
    সচিব
    Yewcourt Lodge Cobcroft Lane
    Cridling Stubbs
    WF11 0AZ Knottingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director48739550003
    NEWMAN, Louise Jane
    23 Amaranth Way
    Up Hatherley
    GL51 3YU Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    23 Amaranth Way
    Up Hatherley
    GL51 3YU Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant76524090001
    BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    900001040001
    ANDERSSON, Lena Maria
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    EnglandFinnishChief Financial Officer193565700001
    DICKENS, Nigel William
    Yewcourt Lodge Cobcroft Lane
    Cridling Stubbs
    WF11 0AZ Knottingley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Yewcourt Lodge Cobcroft Lane
    Cridling Stubbs
    WF11 0AZ Knottingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director48739550003
    DREWERY, Eric
    33 Cresta House
    133 Finchley Road
    NW3 6HT London
    পরিচালক
    33 Cresta House
    133 Finchley Road
    NW3 6HT London
    BritishChief Executive Officer1986310003
    FISKEN, Thomas
    Charis
    Old Smithy Road
    TF10 8PR Tibberton
    Shropshire
    পরিচালক
    Charis
    Old Smithy Road
    TF10 8PR Tibberton
    Shropshire
    BritishManaging Director140748080001
    FUNNELL, Ian Grant
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer195421140001
    GREGORY, Trevor John
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector62944480001
    HAYTON, Christopher James
    16 Langtree Close
    Ellenbrook, Worsley
    M28 7XT Manchester
    পরিচালক
    16 Langtree Close
    Ellenbrook, Worsley
    M28 7XT Manchester
    BritishEngineer99757040001
    HELLENBERG, Remko
    Noordenseweg 7a
    2421 XW Nieuwkoop
    Zuid-Holland
    Netherlands
    পরিচালক
    Noordenseweg 7a
    2421 XW Nieuwkoop
    Zuid-Holland
    Netherlands
    DutchCompany Director61179910001
    HONEYMAN, Alexander Hughes
    80 Angus Road
    PH2 6RB Scone
    Perthshire
    পরিচালক
    80 Angus Road
    PH2 6RB Scone
    Perthshire
    United KingdomBritishComercial Director213163040001
    LAND, Gerrit Frederik
    Botterstraat 141
    5081 JW Elburg
    Gelderland
    The Netherlands
    পরিচালক
    Botterstraat 141
    5081 JW Elburg
    Gelderland
    The Netherlands
    DutchCompany Director61179970001
    MCLAUGHLIN, William
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BT Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director93697590003
    SHEPPARD, Philip Charles
    7 Linnet Lane
    FY8 4AJ Lytham St. Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Linnet Lane
    FY8 4AJ Lytham St. Annes
    Lancashire
    BritishEngineer71428750001
    TAN, Wun Bing
    8 Hatherley Gate
    GL51 6DT Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    8 Hatherley Gate
    GL51 6DT Cheltenham
    Gloucestershire
    SingaporeEngineer75757480001
    UILING, Hendrik Jan
    Knibbelweg 68
    Zevenhuizen
    The Netherlands 2761 Je
    পরিচালক
    Knibbelweg 68
    Zevenhuizen
    The Netherlands 2761 Je
    DutchDirector62342890001
    ZANTINGH, Jan Gerrit
    Bennebroker Weg G2
    Rusenhout
    FOREIGN Noord Holland
    The Netherlands
    পরিচালক
    Bennebroker Weg G2
    Rusenhout
    FOREIGN Noord Holland
    The Netherlands
    DutchManaging Director48888600001

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Abb Holdings Limited
    Daresbury Park
    WA4 4BT Warrington
    3100
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Daresbury Park
    WA4 4BT Warrington
    3100
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Liimted Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish
    নিবন্ধিত স্থানThe Registrar Of Companies Uk
    নিবন্ধন নম্বর02923872
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security assignment schedule
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest in the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security assignment schedule
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies due from mid staffordshire general hospital nhs trust under an offer dates 17 february 2003 with all right, title, benefit and interest, and full benefit of any guarantees, indemnities, debentures, mortgages, charges, insurance claims and other securities and all interest in the equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of assignment by way of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master hire purchase agreement dated 15 may 2000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rentals due or to become due and the benefits relating to the equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as zantingh energy systems limited to the chargee under a lease dated 16TH october 1998
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £3,110.00 which was deposited with the chargees on 16TH october 1998 and with all net interest earnings accruing thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Apreit Iv Limited
    • Apreit Iv Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of assignment by way of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies and other payments due and to become due under or by virtue of the krupp agreement and all other of its rights and benefits thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First Roodhill Leasing Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a lease/hire purchase/rental agreement (the lease agreement) dated 19TH march 1997 or the deed of assignment
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right title benefit and interest present and future under or arising out of or in respect of the sub-hire agreements and all monies due or owing to the company under or arising out of the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • De Lage Landen Leasing Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    ABB COMBINED HEAT AND POWER LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ মার্চ, ২০২০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৯ জুন, ২০২১ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0