HAWKDECIDE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHAWKDECIDE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03231044
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HAWKDECIDE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9234) /

    HAWKDECIDE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    85 Springfield Road
    Chelmsford
    CM2 6JL Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HAWKDECIDE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    HAWKDECIDE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ আগ, ২০১০

    ১০ আগ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Christopher William Goldsmith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363s

    HAWKDECIDE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOLDSMITH, Christopher William
    85 Springfield Road
    Chelmsford
    CM2 6JL Essex
    পরিচালক
    85 Springfield Road
    Chelmsford
    CM2 6JL Essex
    United KingdomBritish13230340005
    BARNES, Sara Anne
    Parkfields Farm
    Beazley End
    CM7 5JJ Braintree
    Essex
    সচিব
    Parkfields Farm
    Beazley End
    CM7 5JJ Braintree
    Essex
    British98921440001
    GOLDSMITH, Christopher William
    Ringers Farmhouse
    Terling Hall Road
    CM3 2BX Terling
    Essex
    সচিব
    Ringers Farmhouse
    Terling Hall Road
    CM3 2BX Terling
    Essex
    British13230340005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNES, Sara Anne
    Parkfields Farm
    Beazley End
    CM7 5JJ Braintree
    Essex
    পরিচালক
    Parkfields Farm
    Beazley End
    CM7 5JJ Braintree
    Essex
    United KingdomBritish98921440001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    পরিচালক
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    পরিচালক
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    HOLMES, Colin Robert
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    পরিচালক
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    United KingdomBritish8041680001
    HUGHSON, David Callum
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    পরিচালক
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    British62284790002
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    পরিচালক
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    পরিচালক
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MOULDER, Stuart Christopher
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    পরিচালক
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish46329920001
    PARDOE, Richard Grenville
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish141544990001
    SCOTT, Nicholas Peter
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    পরিচালক
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish108455130001
    TAME, Russell
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    British117422530001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HAWKDECIDE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Marine mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64 shares in the ship "perfect ten" official no 912067 and in its appurtenances.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Marine mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £92,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    X35 hull id no. Dk-XYA35037C606.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the turnstone estates limited and any other company which is a holding or subsidiary of turnstone estates limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights,titles,benefits and interests under the leases in respect of b & q valleybridge rd,clacton on sea. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the turnstone estates limited and any other company which is a holding or subsidiary of turnstone estates limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as b & q valleybridge rd,clacton on sea ;ex 461132; all buildings,erections,fixtures,fittings,equipment,fixed plant and machinery thereon and all moneys deposited. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,037,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings k/a red lion buildings 12 cock lane london and a floating charge over the undertaking property assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0