THORPE KILWORTH LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHORPE KILWORTH LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03255706
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THORPE KILWORTH LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2030) /
    • (2051) /
    • (4542) /

    THORPE KILWORTH LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Victory House
    Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THORPE KILWORTH LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INGLEBY (942) LIMITED২৭ সেপ, ১৯৯৬২৭ সেপ, ১৯৯৬

    THORPE KILWORTH LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০০৮

    THORPE KILWORTH LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    THORPE KILWORTH LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টের নোটিশ দ্রবীভূত হওয়ার আগে

    1 পৃষ্ঠা4.43

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা4.31

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    পৃষ্ঠাCOCOMP

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:C.O. To remove liquidator Simon Paterson
    11 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    দেউলিয়া আবেদন

    INSOLVENCY:annual progress report for period up to 22/02/2015
    7 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:progress report 23/02/12 to 22/02/13
    9 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    COCOMP

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা4.31

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    2 পৃষ্ঠাCOCOMP

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    1 পৃষ্ঠাCOCOMP

    প্রশাসনের সমাপ্তির আদালতের আদেশের নোটিশ

    11 পৃষ্ঠা2.33B

    ০৩ জুন, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    11 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ০৩ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    23 পৃষ্ঠা2.17B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    THORPE KILWORTH LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WARD, Paul James
    11 St Peters Close
    Glenfield
    LE3 8QB Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    11 St Peters Close
    Glenfield
    LE3 8QB Leicester
    Leicestershire
    British97124730001
    BACKHOUSE, Alan Clarke
    Bramley House
    Coventry Road
    CV23 9HB Church Lawford
    Warwickshire
    পরিচালক
    Bramley House
    Coventry Road
    CV23 9HB Church Lawford
    Warwickshire
    EnglandBritishOperations Director73534350001
    CRAWFORD, Joseph
    Craigearn Avenue
    KY2 6YS Kirkcaldy
    2
    Fife
    পরিচালক
    Craigearn Avenue
    KY2 6YS Kirkcaldy
    2
    Fife
    BritishBsf Director137634960001
    HOLYOAK, John Raymond
    17 Long Grey
    Fleckney
    LE8 8TB Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    17 Long Grey
    Fleckney
    LE8 8TB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishOperations Manager92908890001
    LOGUE, Neil Joseph
    The Stable House
    Lutterworth Road, North Kilworth
    LE17 6JE Lutterworth
    Leicestershire
    পরিচালক
    The Stable House
    Lutterworth Road, North Kilworth
    LE17 6JE Lutterworth
    Leicestershire
    United KingdomIrishDirector151942010001
    ROWLEY, John Thomas
    16 Ashbourne Drive
    Desborough
    NN14 2XG Kettering
    Northamptonshire
    পরিচালক
    16 Ashbourne Drive
    Desborough
    NN14 2XG Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishAccountant27722370001
    STAIN, Ian Edward
    Delamere Station Road
    Old Arley
    CV7 8FG Coventry
    West Midlands
    পরিচালক
    Delamere Station Road
    Old Arley
    CV7 8FG Coventry
    West Midlands
    BritishOrganisational Development122990030001
    WARD, Paul James
    11 St Peters Close
    Glenfield
    LE3 8QB Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    11 St Peters Close
    Glenfield
    LE3 8QB Leicester
    Leicestershire
    BritishTax Adviser97124730001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    CUNNELL, Andrew
    8 The Avenue
    Blackwell
    B60 1BW Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    8 The Avenue
    Blackwell
    B60 1BW Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishFinancial Consultant82038200001
    JONES, David
    148a Portland Road
    Hucknall
    NG15 7SA Nottingham
    পরিচালক
    148a Portland Road
    Hucknall
    NG15 7SA Nottingham
    BritishDirector55788940001
    KNOWLES, Stephen Roger
    Bramble Cottage Pooks Green
    Marchwood
    SO40 4WQ Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    Bramble Cottage Pooks Green
    Marchwood
    SO40 4WQ Southampton
    Hampshire
    BritishQuanity Surveyor48688350002
    PEATFIELD, Malcolm, Dr
    Hilltop House
    7 High Street
    LE9 7DH Earl Shilton
    Leicestershire
    পরিচালক
    Hilltop House
    7 High Street
    LE9 7DH Earl Shilton
    Leicestershire
    BritishBusiness Development Director92428850001
    PEMBLINGTON, David
    18 Ashford Rise
    NG17 2BB Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    18 Ashford Rise
    NG17 2BB Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    BritishDirector14589240001
    WILSHER, Michael John
    Tanglewood Main Road
    NN6 7UY Watford Village
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Tanglewood Main Road
    NN6 7UY Watford Village
    Northamptonshire
    BritishCompany Director52179990001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    THORPE KILWORTH LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Liquidity Limited (The "Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Neil Logue
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Neil Logue
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Euro Sales Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The United Kingdom Branch of Ecredit Ab
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Morbidelli type author 504 cnc point to point multi head boring machine with 15KVA transformer, hankison compressor air drier, rietshcle vacuum pump tria 7500V cnc control system s/no.A1-1043 and morbidelli type U41 cnc point to point multi head boring machine with ebac TD20 air drier, type FS8508 cnc control system s/no.6G7. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Kilworth Group Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    THORPE KILWORTH LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ জুন, ২০১০প্রশাসন শুরু
    ২৪ অক্টো, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Carl Derek Faulds
    1580 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1580 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Hampshire
    Michael Ian Field
    1640 Parkway
    Solent Business Park
    PO15 7AH Whiteley, Fareham
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1640 Parkway
    Solent Business Park
    PO15 7AH Whiteley, Fareham
    Hampshire
    James Richard Tickell
    1640 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AH Fareham
    অভ্যাসকারী
    1640 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AH Fareham
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৮ ফেব, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১৮ জুল, ২০১১আবেদন তারিখ
    ২৪ অক্টো, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৫ মে, ২০১৬ভেঙে গেছে
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon Geoffrey Paterson
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    অভ্যাসকারী
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    The Official Receiver Or Northampton
    Sol House
    29 St Katherines Street
    NN1 2QZ Northampton
    অভ্যাসকারী
    Sol House
    29 St Katherines Street
    NN1 2QZ Northampton
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    অভ্যাসকারী
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Diane Elizabeth Hill
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    অভ্যাসকারী
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Ronald Elliott
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    অভ্যাসকারী
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    অভ্যাসকারী
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0