GREENWICH REACH 2000 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGREENWICH REACH 2000 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03264630
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7032) /

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DE FACTO 536 LIMITED১৭ অক্টো, ১৯৯৬১৭ অক্টো, ১৯৯৬

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    পরিচালক হিসাবে Christopher Odom এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৫ ডিসে, ২০০৯ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে David Silverman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Paul Williams এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Simon Silver এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Nigel George এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    অডিটরের পদত্যাগ

    4 পৃষ্ঠাAUD

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KITE, Timothy James
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    সচিব
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    British107553690001
    BURNS, John David
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    পরিচালক
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    United KingdomBritish9820610002
    MITCHLEY, Simon Colin
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    সচিব
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    British53655170004
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    সচিব
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BURNS, Andrea Gillian
    8 Oakeshott Avenue
    Highgate
    N6 6NS London
    পরিচালক
    8 Oakeshott Avenue
    Highgate
    N6 6NS London
    British51892560002
    DRIVER, Nicholas Gordon Ellis
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    EnglandBritish8811170002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    পরিচালক
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    GEORGE, Nigel Quentin
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    পরিচালক
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    EnglandBritish26640150004
    GROVES, Nicholas Thomas Julian
    37 Vicarage Road
    East Sheen
    SW14 8PZ London
    পরিচালক
    37 Vicarage Road
    East Sheen
    SW14 8PZ London
    United KingdomBritish157469310001
    MICHELL, Andrew Charles
    40 Fernhurst Road
    SW6 7JW London
    পরিচালক
    40 Fernhurst Road
    SW6 7JW London
    United KingdomBritish42286090002
    MORRIS, Howard Royston
    Old Ford Cottage
    SO3 1LD Warnford
    Hampshire
    পরিচালক
    Old Ford Cottage
    SO3 1LD Warnford
    Hampshire
    British42286140001
    ODOM, Christopher James
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    পরিচালক
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    British20951000001
    PEXTON, Martin Andrew
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    পরিচালক
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    EnglandBritish87643530001
    RAYNE, Robert Anthony, The Honourable
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    পরিচালক
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    EnglandBritish53009350001
    SILVER, Simon Paul
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    পরিচালক
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    EnglandBritish35534690001
    SILVERMAN, David Gary
    10 Heath Close
    NW11 7DX London
    পরিচালক
    10 Heath Close
    NW11 7DX London
    United KingdomBritish126851570001
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    পরিচালক
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    WALLIS, Leonard David James
    8 Oakeshott Avenue
    N6 6NS London
    পরিচালক
    8 Oakeshott Avenue
    N6 6NS London
    British35530840002
    WILLIAMS, Paul Malcolm
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10072820003
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A trust deed made between london merchant securities PLC (the "issuer") certain of its subsidiaries (including the company) and the law debenture trust corporation P.L.C. (the "trustee") constituting and securing £100,000,000 6 1/2 per cent.secured bonds due 2026 of the company (the "original bonds)(all terms as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The total amount guaranteed by the company under the trust deed being the total amount payable by the issuer or any substitute principal debtor (as defined) under the trust deed, namely, the principal of, premium (if any) and interest on, the original bonds and on all (if any) further bonds (as defined) which may be created and issued and constitued and secured by a trust deed supplemental to the trust deed and all other monies intended to be secured by or payable under or pursuant to the trust deed or any trust deed supplemental thereto (such principal premium (if any) interest and other monies together the secured amounts)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first floating charge (the "floating charge") by the company in favour of the trustee over all its undertaking property and assets both present and future wheresoever situate (including any uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Trustee for the Holders Ofthe Bonds
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ নভে, ২০০১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    GREENWICH REACH 2000 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩০ মার্চ, ২০১১ভেঙে গেছে
    ১৫ ডিসে, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0