CAIRNMUIR LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAIRNMUIR LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03272296
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAIRNMUIR LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য বিশেষায়িত নির্মাণ ক্রিয়াকলাপ (43999) / নির্মাণ

    CAIRNMUIR LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Loxley Manor Loxley Road
    Sheffield
    S6 6RW South Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAIRNMUIR LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    CAIRNMUIR LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CAIRNMUIR LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    উইন্ডিং আপের সমাপ্তি

    1 পৃষ্ঠাL64.07

    ১৮ আগ, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Tmf Corporate Administration Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    2 পৃষ্ঠাCOCOMP

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৪ নভে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew David Watson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ নভে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Roderick Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ নভে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Silverdell Plc-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ নভে, ২০১৩

    ০৫ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 30,200
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    15 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Company business 08/08/2013
    RES13

    ২৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Mr Sean Edward Harrison Nutley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Mr Ian Roderick Johnson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৬ অক্টো, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Tmf Corporate Administration Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ২৬ অক্টো, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Stewart John Astley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    legacy

    8 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    7 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    CAIRNMUIR LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NUTLEY, Sean Edward Harrison
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    পরিচালক
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomEnglishDirector165427960001
    SILVERDELL PLC
    Buckingham Street
    WC2N 6EF London
    20
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Buckingham Street
    WC2N 6EF London
    20
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর5755897
    182984530001
    ASTLEY, Stewart John
    1 Cameron Court
    Winwick Quay
    WA2 8RE Warrington
    Cheshire
    সচিব
    1 Cameron Court
    Winwick Quay
    WA2 8RE Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Director125296490001
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    সচিব
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    BritishInformation Consultant35994320001
    HARNEY, Michael Brennan
    13 Fairfield Gardens
    Stockton Heath
    WA4 2BX Warrington
    Cheshire
    সচিব
    13 Fairfield Gardens
    Stockton Heath
    WA4 2BX Warrington
    Cheshire
    BritishCompany Secretary2032060001
    NEEDHAM, Michael John
    38 Lower Road
    Chalfont St Peter
    SL9 9AB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    সচিব
    38 Lower Road
    Chalfont St Peter
    SL9 9AB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director46524850003
    PENNA, Anthony John
    58 Church Road
    Wimbledon
    SW19 5AA London
    সচিব
    58 Church Road
    Wimbledon
    SW19 5AA London
    British5276140001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর06902863
    140723560001
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    পরিচালক
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant35994320001
    DOLAN, Joanne Elizabeth
    21 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Cheshire
    পরিচালক
    21 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Cheshire
    BritishStudent51119230001
    DOLAN, Peter
    21 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    21 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Warrington
    Cheshire
    BritishCompany Director21760970001
    FARRELL, John Patrick
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    পরিচালক
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    United KingdomBritishCompany Director702300001
    HOLDSWORTH, Donald
    40 St Anns Close
    Badger Farm
    SO22 4LQ Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    40 St Anns Close
    Badger Farm
    SO22 4LQ Winchester
    Hampshire
    BritishSales Director57926180001
    JOHNSON, Ian Roderick
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    পরিচালক
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165340590001
    NEEDHAM, Michael John
    38 Lower Road
    Chalfont St Peter
    SL9 9AB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    38 Lower Road
    Chalfont St Peter
    SL9 9AB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director46524850003
    PAYNE, Brian John
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    পরিচালক
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant38688940001
    SIMS, Christopher John
    21 Davis Close
    Barrs Court
    BS30 7BU Bristol
    পরিচালক
    21 Davis Close
    Barrs Court
    BS30 7BU Bristol
    EnglandBritishDirector71938490001
    WATSON, Andrew David
    Loxley Road
    Sheffield
    S6 6RW South Yorkshire
    Loxley Manor
    United Kingdom
    পরিচালক
    Loxley Road
    Sheffield
    S6 6RW South Yorkshire
    Loxley Manor
    United Kingdom
    United KingdomBritishOps Director60735110002

    CAIRNMUIR LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Darren James Palin
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১০ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Andrew Owen Mcgee
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১০ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries and the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৩ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Murray Johnstone Limited as Security Trustee for Itself and the Stockholders (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee provided by the company to the chargee in respect of the obligations of kitsons environmental europe limited under a loan agreement dated 27TH march 1997 and all other monies due under that agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over all undertaking and property of the company including plant and machinery goodwill patents and intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • G & H Montage U.K. Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CAIRNMUIR LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৩ ফেব, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০২ ডিসে, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১২ মার্চ, ২০১৫ভেঙে গেছে
    ০২ ডিসে, ২০১৩আবেদন তারিখ
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or Sheffield
    5th Floor The Balance
    Pinfold Street
    S1 2GU Sheffield
    অভ্যাসকারী
    5th Floor The Balance
    Pinfold Street
    S1 2GU Sheffield

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0