HIDUMINIUM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHIDUMINIUM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03292358
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HIDUMINIUM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7020) /
    • (7499) /

    HIDUMINIUM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Windsor Road
    Redditch
    B97 6EF Worcestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HIDUMINIUM LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INGLEBY (964) LIMITED১৬ ডিসে, ১৯৯৬১৬ ডিসে, ১৯৯৬

    HIDUMINIUM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১০

    HIDUMINIUM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৪ মার্চ, ২০১১ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ জানু, ২০১১

    ১৩ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000,002
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ০১ এপ্রি, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    পৃষ্ঠা363(288)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    হিসাব ০২ এপ্রি, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    হিসাব ০৩ এপ্রি, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ০২ এপ্রি, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    HIDUMINIUM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WHITE, Nigel Edward
    4 Habershon Court
    Galton Way
    WR9 7ES Droitwich Spa
    Worcestershire
    সচিব
    4 Habershon Court
    Galton Way
    WR9 7ES Droitwich Spa
    Worcestershire
    BritishAccountant118111890001
    MACPHERSON, Archie James
    11 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Solihull
    পরিচালক
    11 Speedwell Drive
    Balsall Common
    CV7 7AU Solihull
    EnglandBritishManager93007580001
    BERRY, Geoffrey Arthur, Mr.
    252 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    সচিব
    252 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    BritishDirector27786450001
    MCCARNEY, Paul Reid
    15 Burlington Road
    S17 3NQ Sheffield
    সচিব
    15 Burlington Road
    S17 3NQ Sheffield
    British37752930002
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BERRY, Geoffrey Arthur, Mr.
    252 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    252 Station Road
    Knowle
    B93 0ES Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector27786450001
    HARDY, Paul James
    34 Kenwood Park Road
    S7 1NF Sheffield
    পরিচালক
    34 Kenwood Park Road
    S7 1NF Sheffield
    EnglandBritishCompany Director7269800003
    LANGSTON, Paul Royden
    29 Brotherton Avenue
    Webheath
    B97 5JA Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    29 Brotherton Avenue
    Webheath
    B97 5JA Redditch
    Worcestershire
    BritishOperations Director52416880001
    MASTERS, Peter John Ronald
    164 The Ridgeway
    Astwood Bank
    B96 6NJ Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    164 The Ridgeway
    Astwood Bank
    B96 6NJ Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector27786470001
    MCCARNEY, Paul Reid
    15 Burlington Road
    S17 3NQ Sheffield
    পরিচালক
    15 Burlington Road
    S17 3NQ Sheffield
    BritishAccountant37752930002
    MOORE, Brian Stanley
    Mantine House
    Silver Street Chacombe
    OX17 2JR Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Mantine House
    Silver Street Chacombe
    OX17 2JR Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director2688060001
    SCANLON, Anthony John, Dr
    46 The Shrubberies
    CV4 7EF Coventry
    West Midlands
    পরিচালক
    46 The Shrubberies
    CV4 7EF Coventry
    West Midlands
    BritishChief Executive12469440001
    SMITH, David William
    22 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    পরিচালক
    22 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    United KingdomBritishCompany Director27786480003
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    HIDUMINIUM LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security accession deed (the "security accession deed") between 1) hiduminium limited (the new charging company) 2) mettis group limited and 3) dresdner bank ag london branch (the "security trustee") to a debenture dated 13 september 2000 (the "debenture")
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities due owing or incurred to each beneficiary (as defined) by the new charging company or any other company (except as a guarantor for the new charging company) under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    ব্যবসায়
    • ২৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of off-set
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by the principal debtors (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys at any time standing to the credit of the account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to each beneficiary (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as ingleby (964) limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the guarantee and debenture as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Btr Industries Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    HIDUMINIUM LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ মার্চ, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ৩০ এপ্রি, ২০১২ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Laura May Waters
    12 Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    অভ্যাসকারী
    12 Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0