PCV HP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPCV HP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03296331
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PCV HP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    PCV HP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PCV HP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP LIMITED২৪ ডিসে, ১৯৯৬২৪ ডিসে, ১৯৯৬

    PCV HP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    PCV HP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২২ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২২ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাLIQ03

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    ২২ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.40

    ২২ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠা4.68

    ১২ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB থেকে 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ১৬ অক্টো, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ থেকে 8 Salisbury Square London EC4Y 8BBপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    7 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৩ সেপ, ২০১৪ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ অক্টো, ২০১৩

    ২৫ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ১৭ সেপ, ২০১২ তারিখে Mr Nicholas Mark Leslau-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr David Leonard Grose-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    PCV HP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    সচিব
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    পরিচালক
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    পরিচালক
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    কর্পোরেট সচিব
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    পরিচালক
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    পরিচালক
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    পরিচালক
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    পরিচালক
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    পরিচালক
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    পরিচালক
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    পরিচালক
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    পরিচালক
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    FP FINANCIAL LDC
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    49335910001

    PCV HP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 73 and 75 high street,rhyl title absolute under t/n WA493457 for further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp limited) each chargor and the security trustee
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ২১ ফেব, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of: 53 high street newcastle under lyme,64 high street and black swan yard andover,53/55 high street goldaming,2/3 west street farnham,41 fore street trowbridge.for further details of property charged please refer to form 395.other than sums due to the company by way of insurance rent service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security and any proceeds of the forgoing.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    53 high street newcastle under lyme-SF260136;53/55 high street godalming-SY287174;2/3 west street farnham-SY149465 and SY494929 for further details of property charged please refer to form 395.together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    41 fore street trowbridge wiltshire WT145469,11 exchange walk nottingham NT304339,8 high street banbury t/n ON132306 and other properties with all buildings erection fixtures fittings underleases and agreement please refer to form 395 for details of further chrged properties and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Any Other Lender or Any Lender
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land being 48/50 south street romford egl 207769 with all buildings erections and fixtures (inc, trade fixtures) fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment and release
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rents arising in respect of 48/50 south street romford egl 207769.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any lender (as defined) or for or in respect of which the company may be liable to the chargee or any lender on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole right title and interest in the assigned rights being all the rights titles benefits and interests of the company to the rents including the rights to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage (General) Limitedas Trustee for Itself and the Other Lenders ("the Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The properties being 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over all property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment by way of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By clause 2 of the assignment all rights, titles, benefits and interests to all monies incurred to the company under occupational lease/s in respect of 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 13TH february 1997
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole those shop premises with ancillary storage and office accomodation on basement ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now generally known as numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Others
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PCV HP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০১ ফেব, ২০১৯ভেঙে গেছে
    ২৩ সেপ, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0