BLU INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBLU INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03325064
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    BLU INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PCO 169 LIMITED২১ ফেব, ১৯৯৭২১ ফেব, ১৯৯৭

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৭

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা652a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    সচিব
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    900013000001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    পরিচালক
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    British2068480001
    BARNES, Eric Malcolm
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British20256100002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    পরিচালক
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    পরিচালক
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    পরিচালক
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    পরিচালক
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritish32809000002
    BURY, David Gordon
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    পরিচালক
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritish114282510002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    পরিচালক
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    HINCHLEY, David
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    British21091680001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MORRIS, David
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    পরিচালক
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    British3442030001
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    পরিচালক
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    EnglandBritish34366280004
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    পরিচালক
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    পরিচালক
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    পরিচালক
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    পরিচালক
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003
    ROSEFIELD, Stephen Michael
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    পরিচালক
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    British51560380002
    TYLER, David Alan
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    পরিচালক
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    British51860290001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    পরিচালক
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritish13547380001

    BLU INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 31 march 1998 (the principal trust deed),as defined,and securing the £100,000,000 6 > per cent.first mortgage debenture bonds 2011 and £200,000,000 6 > per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 of the company (the bonds) and the first supplemental trust deed dated 13 april 1999 (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of the principal of,premium (if any) and all other moneys due or to become due from bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights,title and interest in the leasehold and freehold premises known as (I) 23/25 english st,carlisle; (ii) 35 high st,chelmsford; (iii) 41 oxford st,kidderminster plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited,as Trustee for the Holders of Thebonds
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of the principal of,premium (if any) and interest on the bonds,and any further bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The premises at 20 donegall place,belfast comprised in and held under lease dated 1 august 1929.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The "Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৯ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of the principal of premium (if any) and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H premises comprising part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises forming part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises situate at albertbridge road belfast.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited ("the Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage in relation to a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) (the bonds)
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of the principal of, premium (if any) and interest on the original bonds and all further bonds and all other moneys covenanted to be paid by the company to the chargee (the trustee) under or pursuant to the mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H and l/h premises k/a connswater shopping centre belfast.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes)
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of the principal of, the premium (if any) and interest on the bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the trustee under or pursuant to the trust deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Exchange Trust Company Limited(As Trustee for the Holders of the Bonds)
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ আগ, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৬ আগ, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৯ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0