MARCHPOLE HOLDINGS PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMARCHPOLE HOLDINGS PLC
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03328638
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5142) /

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o GRANT THORNTON LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০৫ এপ্রি, ২০০৮

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    উইন্ডিং আপের সমাপ্তি

    1 পৃষ্ঠাL64.07

    ২৪ আগ, ২০১১ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠাLQ02

    ০৯ নভে, ২০১০ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    ০৯ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    1 পৃষ্ঠাCOCOMP

    ঋণদাতাদের প্রতিবেদনের পর প্রশাসনিক রিসিভারশিপে বিবৃতির বিবৃতি

    55 পৃষ্ঠা3.3

    প্রশাসনিক রিসিভারের প্রতিবেদন

    13 পৃষ্ঠা3.10

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(1)

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ০৫ এপ্রি, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    62 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Company info 23/10/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার কেনার অনুমোদনের রেজুলেশন

    RES09

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা88(2)

    legacy

    2 পৃষ্ঠা123

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বাড়ানোর রেজুলেশন

    RES04
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    legacy

    10 পৃষ্ঠা363s
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    annual-return২১ আগ, ২০০৮

    legacy

    363(353)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    সচিব
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British1239130001
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    পরিচালক
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    United KingdomBritish91547170001
    LADOW, Allan
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    পরিচালক
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    Swedish132918310001
    MOLLOY, John Patrick
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    পরিচালক
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    EnglandBritish125361860001
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    পরিচালক
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    পরিচালক
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    পরিচালক
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritish1239130001
    STIRLING, Ronald Edward
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    পরিচালক
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    British20434210001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    সচিব
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    সচিব
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    British83282010001
    KIERNAN, James Francis
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    সচিব
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    British87389050001
    TAHMASEBI, Khosrow
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    সচিব
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    British38518070001
    TAYLOR, Charles Robert
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    সচিব
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    British72657510001
    WIEDER, Robert
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    সচিব
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    British85513530001
    ALLNER, Christopher Charles
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78206300001
    BIGNALL, John
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    পরিচালক
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    British907580001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    British5733500001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    পরিচালক
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    BUTLER, Roger John
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    পরিচালক
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    British3453620004
    CAPLIN, Anthony Lindsay
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    পরিচালক
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    United KingdomBritish139900020001
    COX, Andrew Douglas
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    পরিচালক
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    British101923580001
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritish169894800001
    GRAY, Ian Archie
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    পরিচালক
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish115801110001
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    পরিচালক
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    United KingdomBritish83282010001
    HARRISON, John
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    পরিচালক
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    EnglandBritish104830840001
    JOHNSON, Adrian Robert Barnett
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    পরিচালক
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    British57119570001
    KERR-MUIR, James Rodier
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    পরিচালক
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    British37895700002
    MACAULAY, John Arnold
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    পরিচালক
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish154398330001
    MATTEY, David Gary
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    পরিচালক
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    EnglandBritish7199250004
    MELBOURN, John William
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    পরিচালক
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    EnglandBritish6081080001
    MESSIK, John Charles
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    পরিচালক
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    British41030750004
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    পরিচালক
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    MOSS, David Harry
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    পরিচালক
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    United KingdomBritish93660650001
    REYNOLDS, Adam
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    পরিচালক
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    United KingdomBritish85661680003
    SANTELL, Hilary Anne
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    পরিচালক
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    British66561080002

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Atlas
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Pledge of quota
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pledge over all quota owned by the company in J.C.de castelbajac italy srl and any rights attached to that quota.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Agreement for the pledge of account of financial instruments relating to shares of jean-charles de castelbajac S.A.
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pledge over all shares and financial instruments owned by the company in jean-charles de castelbajac S.A. and any rights attached to those shares and financial instruments.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pledge over all membership interests owned by the company in moda america llc and any rights attached to those membership interests.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge over shares in marchpole hong kong limited
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all shares owned by the company in marchpole hong kong limited and any rights attached to those shares.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge over shares in J.c de castelbajac hong kong limited
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all shares owned by the company in J.c de castelbajac hong kong limited and any rights attached to those shares.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ নভে, ২০০৮একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • ০৫ জানু, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • 1২২ জুল, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (LQ02)
      • মামলা নম্বর 1
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The sum of £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the entire business and assets of marchpole holdings PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Downash Consulting Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over book debts
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a 19/20 berners street london W1 t/n NGL724255. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to deed of assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All amounts of principal interest or otherwise and obligations which at any time after 5TH april 1997 may be due owing or incurred under the loan note instrument and the notes by the company to the noteholders (as defined) and/or the chargee (as trustee) up to but not exceeding £10,000 000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Policy number 24276-088-das and 24277-088-das on the life of michael morris in the sum of £5,000,000 and £5,000,000 with allied dunbar assurance PLC with all bonuses accrued.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and the notes up to but not exceeding £10,000,000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee the policy and monies inlcuding bonuses on the life of michael morris policy number 24276-081-das & 24277-081-das for £5,000,000 and £5000,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    প্রশাসনিক রিসিভার
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    প্রশাসনিক রিসিভার
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৬ জুন, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১৪ মে, ২০০৯আবেদন তারিখ
    ০১ জুল, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২২ সেপ, ২০১৫ভেঙে গেছে
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    অভ্যাসকারী
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0