P I H HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামP I H HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03335609
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    P I H HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নির্মাণ হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম (64203) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    P I H HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    P I H HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SHELFCO (NO. 1330) LIMITED১৯ মার্চ, ১৯৯৭১৯ মার্চ, ১৯৯৭

    P I H HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৪

    P I H HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৯ মার্চ, ২০২৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০২ এপ্রি, ২০২৬
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৯ মার্চ, ২০২৫
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    P I H HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    48 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    ১১ আগ, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mauro Piasere-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ আগ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Frederic Castrec এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Bjarne Christopher Petersen Sanne-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    44 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    2 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ জুল, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Duncan Holland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ জুল, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Philip Nicholas Lanigan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩১ জুল, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Duncan Holland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জুল, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Nicholas Lanigan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ১৬ জুন, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adam Rhys Wynne Hughes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ মে, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bruno Claudio Oliveira Teixeira এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate Burnley Lancashire BB11 5SW এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    P I H HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOLLAND, Duncan
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    সচিব
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    325687740001
    HOLLAND, Duncan
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    ScotlandBritish325676520001
    MACKAY, James Innes
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    ScotlandBritish108844510001
    MCSHANE, Paul Joseph
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    পরিচালক
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    EnglandIrish218498550002
    PIASERE, Mauro
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    ItalyItalian339904950001
    SANNE, Bjarne Christopher Petersen
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    NorwayNorwegian336627130001
    COSTELLO, Steven John
    3 Europa View
    Sheffield Business Park
    S91XH Sheffield
    Stanley U.K. Holding Ltd.
    England
    England
    সচিব
    3 Europa View
    Sheffield Business Park
    S91XH Sheffield
    Stanley U.K. Holding Ltd.
    England
    England
    186112950001
    COSTELLO, Steven John
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    270
    Berkshire
    United Kingdom
    186116830001
    HAYHURST, Fred
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    সচিব
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    159802310001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    সচিব
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    299618510001
    ROBINSON, Paul James
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    সচিব
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    British61464420001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    ALLEN, Caroline
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    পরিচালক
    Rosendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Farrington Road
    England
    England
    United KingdomBritish241814400001
    BOND, Philip Michael
    Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    5
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    5
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish70384280002
    CAREY, Malcolm Timothy
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    পরিচালক
    Indian Wells Drive
    77069 Houston
    14111
    Texas
    United States
    UsaAmerican135768760001
    CASTREC, Frederic
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    FranceFrench299627840001
    COGZELL, Matthew James
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish157755080001
    COWLEY, John Mitchell
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish153045530001
    DAVISON, Thomas Patrick
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish178471340001
    EVANS, Calvin Paul
    6622 Preston Trail
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    পরিচালক
    6622 Preston Trail
    Houston
    Texas 77069
    Usa
    UsaAmerican26160230003
    LAAKE, Gregory Duane
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    পরিচালক
    9410 Brentwood Lake Circle
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    United StatesUnited States104309910001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Farrington Road Rossendale Road
    Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish42734310002
    MOKLAK, Paul Daniel
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    পরিচালক
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish217770510001
    RHODES, Fiona Elizabeth
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    পরিচালক
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    United KingdomBritish200869110001
    ROBINSON, Paul James
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    পরিচালক
    17 Moss Lane
    M33 6QD Sale
    Cheshire
    United KingdomBritish61464420001
    SMILEY, Mark Richard
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    পরিচালক
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    EnglandBritish194271890001
    SMITH, Michael Peter
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    পরিচালক
    Closes Hall
    Stump Cross Lane, Bolton By Bowland
    BB7 4LX Clitheroe
    Lancashire
    British65426730001
    SOOD, Amit Kumar
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    পরিচালক
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    EnglandBritish153181250001
    STUBBS, Susan
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    পরিচালক
    Europa Court
    Sheffield Business Park
    S9 1XE Sheffield
    3
    England
    United KingdomBritish169624400001
    TEIXEIRA, Bruno Claudio Oliveira
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    পরিচালক
    Farrington Road
    Rossendale Road Industrial Estate
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    England
    PortugalPortuguese290495760001
    WENDELL BIGGERS, Mark
    405 Golf Crest Lane
    Austin
    Travis Texas
    Usa
    পরিচালক
    405 Golf Crest Lane
    Austin
    Travis Texas
    Usa
    American80999660001
    WOOD, Delma Dale
    68 Champions Court Place
    77069 Houston
    Texas
    পরিচালক
    68 Champions Court Place
    77069 Houston
    Texas
    American58641180004
    WYNNE HUGHES, Adam Rhys
    Farrington Road
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    পরিচালক
    Farrington Road
    BB11 5SW Burnley
    The Pipeline Centre
    England
    EnglandBritish113722460001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    P I H HOLDINGS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    ১৯ আগ, ২০২২
    Midmill Business Park
    Kintore
    AB51 0QP Inverurie
    Site G Tofthills Avenue
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশScotland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বরSc189419
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Bath Road
    SL1 3YD Slough
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Bath Road
    SL1 3YD Slough
    210
    Berkshire
    United Kingdom
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মUnlimited With Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর01518375
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0