PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03345707
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PERCEPTION INTERACTIVE LIMITED০৪ এপ্রি, ১৯৯৭০৪ এপ্রি, ১৯৯৭

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ মে, ২০১৪

    ১৯ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10
    SH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১৯ মার্চ, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Miss Mary Louise Cole-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ২১ ডিসে, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Susanna Ewing এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২১ ডিসে, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Susanna Ewing এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Susanna Ewing-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Peter Harris এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Jonathan Harris এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ashley Graham Martin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২২ অক্টো, ২০১০ তারিখে Mr Peter John Scott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr Peter Harris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Mr Peter Harris-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২১ এপ্রি, ২০১১The document is a duplicate of AP03 registered on 21/09/2010

    সচিব হিসাবে Peter Scott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr Peter Jonathan Harris-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২১ এপ্রি, ২০১১The document is a duplicate of AP01 registered on 25/05/2010

    সচিব হিসাবে Mr Peter Scott-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COLE, Mary Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    177909100001
    MARTIN, Ashley Graham
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritish169305720001
    SCOTT, Peter John
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    পরিচালক
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    EnglandBritish97249440006
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    সচিব
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    British74800310002
    DOUGHTY, Robert
    24 Colleys Lane
    Willaston
    CW5 6NS Crewe
    Cheshire
    সচিব
    24 Colleys Lane
    Willaston
    CW5 6NS Crewe
    Cheshire
    British52650930001
    EWING, Susanna
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    171623370001
    HARRIS, Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    154267260001
    SCOTT, Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    151533590001
    VALPY, Rupert James Nevill
    2 Blackford Road
    EH9 2DS Edinburgh
    সচিব
    2 Blackford Road
    EH9 2DS Edinburgh
    British37662340002
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    CARTER, Edward Timothy John, Doctor
    15 Comely Bank Avenue
    EH4 1EW Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    15 Comely Bank Avenue
    EH4 1EW Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish69289540001
    CROWE, Jeremy David Macdonald, Dr
    6 Thirlestane Road
    EH9 1AN Edinburgh
    পরিচালক
    6 Thirlestane Road
    EH9 1AN Edinburgh
    British61273090002
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish74800310002
    DOUGHTY, Jon Steven
    Flat 1 13 Shad Thames
    SE1 2PB London
    পরিচালক
    Flat 1 13 Shad Thames
    SE1 2PB London
    British58691650002
    DOUGHTY, Robert
    24 Colleys Lane
    Willaston
    CW5 6NS Crewe
    Cheshire
    পরিচালক
    24 Colleys Lane
    Willaston
    CW5 6NS Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish52650930001
    HAMER, Jeremy John
    Great Down Farm
    Marnhull
    DT10 1JY Sturminster Newton
    Dorset
    পরিচালক
    Great Down Farm
    Marnhull
    DT10 1JY Sturminster Newton
    Dorset
    EnglandBritish10425110003
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    EnglandBritish40917640001
    VALPY, Rupert James Nevill
    2 Blackford Road
    EH9 2DS Edinburgh
    পরিচালক
    2 Blackford Road
    EH9 2DS Edinburgh
    British37662340002
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    PERCEPTION DIGITAL MEDIA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge on all debts and related rights and floating charge on all other property
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated 24TH july 2001 made between the company and the security holder ("the agreement") or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all (a) specified debts being any book debts the ownership of which shall fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (b) all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever; by way of floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First National Invoice Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0