MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03358076
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MINERVA PROPERTY HOLDINGS PLC১২ জুন, ১৯৯৭১২ জুন, ১৯৯৭
    TRADEFIGURE PUBLIC LIMITED COMPANY২২ এপ্রি, ১৯৯৭২২ এপ্রি, ১৯৯৭

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১১ মে, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১১ মে, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১১ মে, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Colin Barry Wagman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Jonathan Goswell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    ০৮ জুন, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 40 Queen Anne Street London W1G 9EL থেকে 26-28 Bedford Row London WC1R 4HEপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১২ মে, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael George Cohen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Anthony Piper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ সেপ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael George Cohen-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Anthony Piper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Holroyd এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Anthony Piper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Jonathan Goswell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael George Cohen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector202597650001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    সচিব
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector56155670004
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    সচিব
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLEE, Rodney
    7 Boxworth Close
    North Finchley
    N12 9HJ London
    পরিচালক
    7 Boxworth Close
    North Finchley
    N12 9HJ London
    BritishAccountant53537100002
    CHERRY, Mark Christopher
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector69114260002
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    পরিচালক
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    BritishCompany Director35406400003
    DARE, Cliff Roderick Stanton
    Little Manor House
    Bell Hill Hook Norton
    OX15 5NG Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Little Manor House
    Bell Hill Hook Norton
    OX15 5NG Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director79899690001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    পরিচালক
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritishCompany Director76373440001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    পরিচালক
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    United KingdomBritishDirector60475780003
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector106868320001
    HIGSON, John Anthony
    White Gates
    White Cross Zeals
    BA12 6PH Warminster
    Wilts
    পরিচালক
    White Gates
    White Cross Zeals
    BA12 6PH Warminster
    Wilts
    BritishProperty Investment31661220002
    HOLROYD, Peter
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector111330930001
    LAMONT, Alexander Wilson
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    পরিচালক
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    EnglandBritishDirector158518680001
    MOODY, Edward Robert William
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Great BritainBritishDirector62122950001
    MORRIS, Alexander
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector110589420002
    PIPER, James Anthony
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management
    United Kingdom
    পরিচালক
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    পরিচালক
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    RIXON, Arthur John
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector40591390002
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    পরিচালক
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director118467060001
    THOMPSON, Quentin Charles
    17 Graemsdyke Avenue
    East Sheen
    SW14 7BH London
    পরিচালক
    17 Graemsdyke Avenue
    East Sheen
    SW14 7BH London
    EnglandBritishCompany Director33552230002
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6h Floor, Lansdowne House
    England
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6h Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant189915990001
    YEWMAN, Steven John
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector45742320002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Minerva Limited
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegister Of Companies England And Wales
    নিবন্ধন নম্বর02649607
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Third party charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from M1 limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge its interest in (a) the investments; and (b) all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The "Agent")
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ আগ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Third party legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 111 cannon street london t/n LN190165. 103 cannon street london t/n NGL822949. F/h 13 st. Swithin's lane, london t/n ngl 558962 (for details of further properties charged please see form 395) and fixed charge its interest in the investments and all dividends interest and other money payable in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch (The "Agent")
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Third party charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge its interest in the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Third party charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The investments and all dividends interest and other money in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Third party charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or the borrowers to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of guarantee and security deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit in the amount of £2,350,000 held in an account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Odeon Cinemas Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Third party charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers and the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge its interest in the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৩ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from hutch investments limited and chainbill limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The investments and any dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A). all shares held by the chargor in the borrower from time to time being at the date of the charge over shares, 2 ordinary shares of £1 each in the borrower held by the chargor which comprise 100% of the issued share capital of the borrower (the "shares") b). I). any dividends distributions or other income from time to time declared paid or made on any of the shares ii). All voting rights in respect of any of the shares iii). And all other benefits money rights or other assets from time to time accruing arising in respect of any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All or any of the present or future or actual or contingent obligations or liabilities due or to become due from M1 limited and/or minerva (ambassador) limited to the chargee or the beneficiaries (as defined) under any finance document (as defined) or under the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2 ordinary shares of £1.00 each in M1 limited and 2 ordinary shares of £1.00 each in minerva (ambassador) limited and all dividends interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present or future obligations or liabilities of gradegilt limited to the beneficiaries under the finance documents and all liabilities of the chargor under the debenture (all defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment and all dividends interest and other monies payable to the chargor in respect of any charged investment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge or any other security document (as defined in the loan agreement) (the obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right title and interest in and to two ordinary shares and all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All or any of the present or future or actual or contingent obligations or liabilities due or to become due from the company to the chargee or the beneficiaries (as defined) under any finance document (as defined) or under the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    100 ordinary shares of £1.00 each issued by the company and all dividends interest and other monies payable.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) arising under or in connection with the guarantee dated 19TH july 1996 and/or minerva PLC under the finance documents (as defined) whether or not originally owed to the beneficiaries and on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole of its both present and future and wheresoever and wheresoever situate for the angelmist shares and the premier land shares. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares (twin tower)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from angelmist limited to the chargee and the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its 99 ordinary shares in twin tower properties limited together with the one share it holds jointly with andrew ian rosenfeld; any investment issued by way of redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of any investment referred to above and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares (helios)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from helios property investments limited to the chargee and the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its 2 ordinary shares in helios; any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment referred to above and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares (angelmist)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from angelmist limited to the chargee and to the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its 2 ordinary shares in angelmist; any investment issued by way of redemption, bonus, preference, option or otherwise in respect of any investment referred to above; and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries arising under the guarantee and/or minerva PLC to the beneficiaries arising under or in connection with the finance documents whether not originally owed to the beneficiaries and on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any investment in any guarantors (excluding twin tower) and any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment referred to above.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ মে, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৪ ডিসে, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    অভ্যাসকারী
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0