AFFINITI (UK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAFFINITI (UK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03361295
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AFFINITI (UK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বিজ্ঞাপন এজেন্সি (73110) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    AFFINITI (UK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Adventis House
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AFFINITI (UK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    W B COMMUNICATIONS LIMITED২৮ এপ্রি, ১৯৯৭২৮ এপ্রি, ১৯৯৭

    AFFINITI (UK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    AFFINITI (UK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১১ জুল, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Andrea Parsons এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ এপ্রি, ২০১২

    ৩০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 11,111
    SH01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    ৩১ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles Macdonald Burton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles Macdonald Burton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Charles Phillpot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Neil Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Pearson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Charles Phillpot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Mrs Andrea Parsons-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Peter Linnell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Peter Linnell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    7 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Peter John Linnell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Stuart Tennant এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Charles John Phillpot-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Neil George Philip Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    AFFINITI (UK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PEARSON, Andrew
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector159777410001
    COLLINS, Allan
    Whitebears
    29 St John's Green
    CM1 3DZ Writtle
    Essex
    সচিব
    Whitebears
    29 St John's Green
    CM1 3DZ Writtle
    Essex
    British46168870003
    LESTER, Graham Hugh
    138
    Eskdale Avenue
    HP5 3BD Chesham
    Buckinghamshire
    সচিব
    138
    Eskdale Avenue
    HP5 3BD Chesham
    Buckinghamshire
    BritishMarketing52491270001
    LINNELL, Peter John
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    সচিব
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    BritishFinance Director63174210002
    PARSONS, Andrea
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    সচিব
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    159032830001
    TENNANT, Stuart William
    Reddings
    8 Green Lane
    HP6 5LN Chesham Bois
    Buckinghamshire
    সচিব
    Reddings
    8 Green Lane
    HP6 5LN Chesham Bois
    Buckinghamshire
    EnglishDesign Consultant36222830001
    TURNER, Beverley Elizabeth
    30 The Avenue
    Oaklands
    AL6 0PP Welwyn
    Hertfordshire
    সচিব
    30 The Avenue
    Oaklands
    AL6 0PP Welwyn
    Hertfordshire
    British17056420002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BURTON, Charles Macdonald
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector52491260001
    GARNER, John Bancroft
    The Long Stone House
    Hellidon
    NN11 6LG Daventry
    Northants
    পরিচালক
    The Long Stone House
    Hellidon
    NN11 6LG Daventry
    Northants
    BritishSales Director34161190001
    LESTER, Graham Hugh
    138
    Eskdale Avenue
    HP5 3BD Chesham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    138
    Eskdale Avenue
    HP5 3BD Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishMarketing52491270001
    LINNELL, Peter John
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    পরিচালক
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    United KingdomBritishFinance Director63174210002
    PHILLPOT, Charles John
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    পরিচালক
    Adventis Group Plc
    93-95 Wigmore Street
    W1U 1HH London
    United KingdomBritishDirector151500570001
    SMITH, Neil George Philip
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    পরিচালক
    Post Office Lane
    HP9 1FN Beaconsfield
    Adventis House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector23699980001
    TENNANT, Stuart William
    Reddings
    8 Green Lane
    HP6 5LN Chesham Bois
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Reddings
    8 Green Lane
    HP6 5LN Chesham Bois
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglishManaging Director36222830001

    AFFINITI (UK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুন, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ ফেব, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ আগ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0