SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03379663
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য সফ্টওয়্যার প্রকাশনা (58290) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DEMOABLE LIMITED০২ জুন, ১৯৯৭০২ জুন, ১৯৯৭

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০১৪

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    11 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৬ মে, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    28 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৭ মে, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ 7 থেকে মুক্ত করা হয়েছে

    5 পৃষ্ঠাMR05

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Paul Woodward-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sanjay Patel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Van Harken-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mary Collins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জুন, ২০১৪

    ০৪ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Misys Corporate Director Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Joanna Hawkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Misys Corporate Secretary Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Sanjay Patel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Elizabeth Mary Collins-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Bijal Patel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Joanna Marageret Hawkes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২০ মে, ২০১৩ তারিখে Mr Bijal Mahendra Patel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Bijal Mahendra Patel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    সচিব
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    British147213550001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    সচিব
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    সচিব
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    সচিব
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    সচিব
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর07036299
    170449400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAULME, Herve
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    পরিচালক
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    French98573020001
    BELLOUARD, Xavier Henry Marie
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    পরিচালক
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    LondonFrench53755850003
    BRIODY, Dermot
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    পরিচালক
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Irish128090250001
    CAPPELL, Mark Stanley
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    United KingdomAmerican103054980001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DE FONTENAY, Jean
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    পরিচালক
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    French53755800002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    পরিচালক
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    পরিচালক
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    HUGHES, Kevin Gerard
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    পরিচালক
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    British2659400001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    পরিচালক
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    পরিচালক
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SARGANT, Murray
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    পরিচালক
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Australian113006830001
    SOAMES, Rupert Christopher
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    ScotlandBritish86671010001
    STONELL, Keith Robert
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish151579610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৮ মে, ২০১৫সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ অক্টো, ২০১৭ভেঙে গেছে
    ২৭ মে, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    অভ্যাসকারী
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0