BEZIER HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBEZIER HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03382134
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    BEZIER HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MECHOPORT LIMITED০৫ জুন, ১৯৯৭০৫ জুন, ১৯৯৭

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১২

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ নভে, ২০১৩

    ১২ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 26,015,020
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পরিচালক হিসাবে Mr Paul Canning-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Steel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    সচিব হিসাবে John Stirling এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    বিবিধ

    Section 519
    2 পৃষ্ঠাMISC

    অডিটরের পদত্যাগ

    4 পৃষ্ঠাAUD

    সচিব হিসাবে John Henry Stirling-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    legacy

    7 পৃষ্ঠাMG01

    পরিচালক হিসাবে Mr James Joseph Michael Faulds-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Richard Barfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew David Steel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Richard Barfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    29 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Trevor O'reilly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    15 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CANNING, Paul
    c/o H.I.G. European Capital Partners Llp
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    England
    পরিচালক
    c/o H.I.G. European Capital Partners Llp
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    England
    United KingdomBritishManaging Director165964000001
    FAULDS, James Joseph Michael
    Silkwood Park
    WF5 9TL Ossett
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Silkwood Park
    WF5 9TL Ossett
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director571840010
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    সচিব
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    149687240001
    DUDLEY, Brian
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    সচিব
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    BritishChief Executive39917050001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    সচিব
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    BritishChartered Accountant129305300001
    LEIGH, Andrew Nigel
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    সচিব
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishFinance Director30205620003
    SHAW, Mark
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    সচিব
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    British146255720001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    সচিব
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    BritishNone107353690001
    STIRLING, John Henry
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    168886450001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector123477010001
    CARNAZZA, Ian Medwin
    32 Leyland Road
    HG1 4RT Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    32 Leyland Road
    HG1 4RT Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director107723490001
    COLLINS, Christopher Henry
    Ardenlea
    7 Fort Road
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Ardenlea
    7 Fort Road
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    BritishFund Manager76935620001
    COURTNEY, Richard Howard
    Upper Mill Farm
    Oakridge Heol Hir
    CF14 9LA Cardiff
    পরিচালক
    Upper Mill Farm
    Oakridge Heol Hir
    CF14 9LA Cardiff
    United KingdomBritishNone153848980001
    DUDLEY, Brian
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    পরিচালক
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    EnglandBritishChief Executive39917050001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    পরিচালক
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant129305300001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    পরিচালক
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritishNone45695650002
    LEIGH, Andrew Nigel
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishFinance Director30205620003
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    IrelandIrishDirector148130760001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritishNone138299060001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritishNone107353690001
    ST JOHN, Charles Henry Oliver
    3 Brodrick Road
    SW17 7DZ London
    পরিচালক
    3 Brodrick Road
    SW17 7DZ London
    BritishInvestment Director55581420001
    STEEL, Andrew David
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    পরিচালক
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritishPrivate Equity Partner142266440002
    SYMONDSON, David Warwick
    10 Prebend Gardens
    Chiswick
    W4 1TW London
    পরিচালক
    10 Prebend Gardens
    Chiswick
    W4 1TW London
    BritishInvestment Director6017570001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    BEZIER HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    An amendment and restatement deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ সেপ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    A security debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Security confirmation and supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A confirmatory deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings lying to the south of church road wick t/no's AV111330,AV111331 and AV128876 and f/h land and builsings on the south side of balne lane wakefield fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A confirmatory deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০৯
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings lying to the south of church road wick t/nos AV111330, AV111331 and AV128876 and f/h land and buildings on the south side of balne lane wakefield t/no WYK516231. By way of fixed charge all shares and all related distribution rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotalnd PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৫ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Keyman insurance assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of assignment the policies and the proceeds and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Keyman insurance assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly k/a mechnoport limited) to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the deed)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to the policies and allmonies and related rights thereto and full benefit thereof policies charged being 1). in the name of brian dudley dated 14TH april 1998 for the sum of £500,000 for the term of 5 years with standard life with policy number X67235989 2). name;-david simpson date:- 14TH april 1998 sum;- £200,000 term;-5 years with standard life policy number;-X67208452 3). name;-mark carr date;-14TH april 1998, sum;- £200,000 term ;-5 years with standard life, policy number;-X67209637 4). stephen mears.date;-14TH april 1998. sum;-£200,000 term 5 years with standard life policy number;-X67218827 5). name ;-wayne romminger.date;-14TH april 1998, sum;-£200,000 term;-5 years with standard life with policy number X67218216. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as mechnoport limited) to the chargees under the terms of the financing documents (as defined in the deed)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property charged being f/h land and buildings on the north side of lealand way boston lincolnshire t/no;-LL872275, f/h land and buildings on the south side of church road wick t/no's;-AV111331, AV111330 and AV128876 and f/h land and buildings on the south side of balne lane wakefield t/no;-WYK516231. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0