GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03391393
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • আর্থিক লীজিং (64910) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Maltings
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    Lincolnshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MARCPRIME LIMITED২৪ জুন, ১৯৯৭২৪ জুন, ১৯৯৭

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৪ জুন, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Genie Uk Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ২৭ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Daniel Sheehan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Patrick Bradley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gerald Eugene Dougherty এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ জুল, ২০১৬

    ০৬ জুল, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ১১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ronald Matthew Defeo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ জুন, ২০১৫

    ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ জুল, ২০১৪

    ১৪ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুল, ২০১৩

    ০২ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    পরিচালক হিসাবে Lawrence Lockwood এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Phillip Widman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Lawrence Lockwood এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kevin Patrick Bradley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Matthew Sean Fearon-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Gerald Eugene Dougherty-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Lawrence Lockwood এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Timothy Ford এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    সচিব
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    পরিচালক
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    FEARON, Matthew Sean
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican176771990001
    GEORGE, Joseph M.
    Bluff Road
    Eden Prairie
    10564
    Mn 55347
    Usa
    পরিচালক
    Bluff Road
    Eden Prairie
    10564
    Mn 55347
    Usa
    United StatesAmerican156295130001
    JUNG, Matthias
    Ch-8260
    Stein Am Rhein
    Alte Zollstrasse 10
    Switzerland
    পরিচালক
    Ch-8260
    Stein Am Rhein
    Alte Zollstrasse 10
    Switzerland
    SwitzerlandGerman159848410001
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    পরিচালক
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    DODEL, Craig
    3030 Ne 182nd
    98155 Seattle
    Wa
    Usa
    সচিব
    3030 Ne 182nd
    98155 Seattle
    Wa
    Usa
    U S Citizen61601480001
    LOCKWOOD, Lawrence Jay
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    সচিব
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    American109968340001
    MATUSCHAK, Stephen John
    6300 North Ridge Drive
    WA98290 Snohomish
    Washington
    Usa
    সচিব
    6300 North Ridge Drive
    WA98290 Snohomish
    Washington
    Usa
    Us Citizen54950900001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BENNETT, Mark
    22 Beech Drive
    NN13 6JH Brackley
    Northamptonshire
    পরিচালক
    22 Beech Drive
    NN13 6JH Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritish127744260001
    BRADLEY, Kevin Patrick
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    BROWN, Frank Roger
    4155 143 Rd Ne
    Bellevue
    Wa 98155
    পরিচালক
    4155 143 Rd Ne
    Bellevue
    Wa 98155
    American74340700001
    BUSHNELL, Sherman Ward
    4638 95th Avenue N E
    98004 Bellevue
    Wa
    Usa
    পরিচালক
    4638 95th Avenue N E
    98004 Bellevue
    Wa
    Usa
    American61601390001
    CARTER, Jonathan David
    14 Terra Nova Circle
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    পরিচালক
    14 Terra Nova Circle
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    British89145060001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    পরিচালক
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOUGHERTY, Gerald Eugene
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    UsaU.S. Citizen176771590001
    FEARON, Matthew Sean
    2609 226th Ave S E
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    পরিচালক
    2609 226th Ave S E
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    United StatesAmerican176771990001
    FORD, Timothy
    6175 Sierra Circle
    Shorewood
    Mn 55331
    Usa
    পরিচালক
    6175 Sierra Circle
    Shorewood
    Mn 55331
    Usa
    UsaAmerican116645520001
    KNOLL, Jerome C
    6051 78th Avenue N E
    NA98040 Mercer Island
    Washington
    Usa
    পরিচালক
    6051 78th Avenue N E
    NA98040 Mercer Island
    Washington
    Usa
    Us Citizen54951090001
    LOCKWOOD, Lawrence Jay
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    পরিচালক
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    UsaAmerican109968340001
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    পরিচালক
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001
    WILKERSON, Robert Ready
    4215 91st Ne
    Bellevue
    Wa 98004
    Usa
    পরিচালক
    4215 91st Ne
    Bellevue
    Wa 98004
    Usa
    American59939290002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Genie Uk Limited
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland & Wales
    নিবন্ধন নম্বর02452185
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from powered access services limited (the company) to the chargee by virtue of its holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by special resolution passed on 15TH august 2001, in a maximum aggregate amount of not more than £400,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assignment by way of security of any receivables due to the assignor under clause 6.01(a) or (b) of the master hire purchase agreement in respect of goods identified in schedule 1 to the master hire purchase agreement dated 25TH may 2001.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fitzwise Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies becoming due and payable from time to time by powered access services limited (the "company") to the chargee by virtue of it's holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by a special resolution on 15TH august 2001 in a maximum aggregate of not more than £400,000 together with all proper costs charges and expenses of or incurred by the chargee pursuant to the debenture dated 15TH august 2001 and granted by the company to the mortgagee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to the equipment and the relevant receivables and all benefits which may arise under the master hire agreement dated 25TH may 2001 between the company and genie financial services (europe) limited. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fitzwise Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master agreement dated 29TH december 1999 and funding schedules (being any documents described as a funding schedule and expressed to be supplementary to the master agreement) together with all other sums incuding costs and interest payable by the company pursuant to such master agreement and/or funding schedules
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to all equipment being the goods let under the terms of the agreements detailed under the charge between the company inclusive of all rights to claim all sums owing or to become owing by the hirer under or in respect of the hire agreements with the following references 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1526,1527,1516 and 1517 together with he proceeds of sale all rights under any licence and all other rights claims in respect of any equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Daimlerchrysler Capital Services (Debis) UK Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of funding schedules and the master agreement dated 1 october 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company assigns to heller the equipment and all the right title and interest of the company goods let under the terms of a funded hire agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Heller Global Vendor Finance UK Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the assignment and a master hire purchase agreement no.57854
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title and interest the contracts the contract earnings the insurances all moneys payable in respect of a totla loss all book and other debts due owing pauable or incurred to the company equipment hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lease Products Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0