CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03396423
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7470) /

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    COASTLINE CLEANING COMPANY LIMITED০২ আগ, ১৯৯৯০২ আগ, ১৯৯৯
    HIRSHFIELDS MANAGEMENT LIMITED০৩ অক্টো, ১৯৯৭০৩ অক্টো, ১৯৯৭
    INVOLINK LIMITED০২ জুল, ১৯৯৭০২ জুল, ১৯৯৭

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ ডিসে, ২০১১

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 1st Floor Pellipar House 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ জুল, ২০১১

    ১৩ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 200
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Andrew Burchall-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Rebecca Jane Watson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Rebecca Jane Watson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    COLEMAN, Paul James
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    সচিব
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British13535920002
    KNIGHT, David Owen
    The White Cottage
    Albury Hall Park
    SG11 2JA Albury Nr Ware
    Herts
    সচিব
    The White Cottage
    Albury Hall Park
    SG11 2JA Albury Nr Ware
    Herts
    British19819490001
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    সচিব
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    সচিব
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    BritishCompany Secretary38346120001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    সচিব
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    সচিব
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    ROOTS, Christopher Peter
    35 Hemingford Road
    SM3 8HG Sutton
    Surrey
    সচিব
    35 Hemingford Road
    SM3 8HG Sutton
    Surrey
    British1441520001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    পরিচালক
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritishManaging Director72452740004
    CHOLERTON, John David
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector9497220001
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director58806030001
    COLEMAN, Paul James
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant13535920002
    CROOKS, James Broumpton
    Horsebridge House
    Kings Somborne
    SO20 6PU Stockbridge
    Hampshire
    পরিচালক
    Horsebridge House
    Kings Somborne
    SO20 6PU Stockbridge
    Hampshire
    BritishChartered Accountant61150710003
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    পরিচালক
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    FERGUSON, Alastair William
    21 Highfield Close
    HP6 6HG Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    21 Highfield Close
    HP6 6HG Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant24470240001
    FOX, Alastair Timothy
    35 Kelmscott Road
    SW11 6QX London
    পরিচালক
    35 Kelmscott Road
    SW11 6QX London
    United KingdomBritishDirector49930800001
    HARRIS, Jonathan David
    5 Telegraph Hill
    Hampstead
    NW3 7NU London
    পরিচালক
    5 Telegraph Hill
    Hampstead
    NW3 7NU London
    United KingdomBritishChartered Surveyor86075300001
    KNIGHT, David Owen
    The White Cottage
    Albury Hall Park
    SG11 2JA Albury Nr Ware
    Herts
    পরিচালক
    The White Cottage
    Albury Hall Park
    SG11 2JA Albury Nr Ware
    Herts
    United KingdomBritishChartered Accountant19819490001
    LAWRIE, Stuart
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director84516540001
    MILLS, Terence Leslie John
    Hunters Lodge
    Lyminster Road, Wick
    BN17 7PS Littlehampton
    West Sussex
    পরিচালক
    Hunters Lodge
    Lyminster Road, Wick
    BN17 7PS Littlehampton
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector65455960001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary38346120001
    PUGH, Ian Russel
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritishDirector61327530003
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant57975730001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001
    ST JAMES'S SERVICES LIMITED
    10 Orange Street
    WC2H 7DQ London
    কর্পোরেট পরিচালক
    10 Orange Street
    WC2H 7DQ London
    38211130002

    CARLISLE PUBLIC SECTOR SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of floating charge between the chargors (as defined) and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the security trustee) for the secured parties (as defined), tracedance limited and capital group limited as security trustee for the secured parties
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilities due or to become due from the chargors to the security trustee under or in respect of the credit agreement, guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each chargor under the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge all undertaking and all assets rights income and goodwill of the company both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0