CHARCOL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCHARCOL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03397767
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CHARCOL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6512) /

    CHARCOL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CHARCOL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JOHN CHARCOL (BIRMINGHAM) LIMITED০৩ জুল, ১৯৯৭০৩ জুল, ১৯৯৭

    CHARCOL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৭

    CHARCOL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠা4.72

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    11 পৃষ্ঠা2.34B

    সচিব হিসাবে Imogen Coggan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Imogen Coggan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Jane Mcmahon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২২ আগ, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    6 পৃষ্ঠা2.24B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    8 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠা2.17B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠা2.17B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    8 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    8 পৃষ্ঠাMG01

    ০১ জানু, ২০০৯ তারিখে Jane Elizabeth Mc Mahon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    9 পৃষ্ঠা395

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    CHARCOL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    AVRILI, Walter Anthony
    Carrick House
    Carrick Lane
    GU46 6XN Yateley
    Hampshire
    পরিচালক
    Carrick House
    Carrick Lane
    GU46 6XN Yateley
    Hampshire
    United KingdomBritishProduct Director102119310001
    GARFIELD, John Stuart Godwin
    2 Farmer Street
    Nottinghill Gate
    W8 7SN London
    পরিচালক
    2 Farmer Street
    Nottinghill Gate
    W8 7SN London
    UkBritishCompany Director22311780012
    LAWTON, Michael John
    Albany Road
    GU51 3LY Fleet
    14
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Albany Road
    GU51 3LY Fleet
    14
    Hampshire
    United Kingdom
    BritishSales Director134156000001
    COGGAN, Imogen Frances Lytton
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    সচিব
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    BritishAccountant134061130001
    FRENKEL, John Richard
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    সচিব
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    BritishAccountant127384780001
    JORDAN, Paul Gary
    Lindale 9 Back O' The Beck
    BD23 1PH Skipton
    North Yorkshire
    সচিব
    Lindale 9 Back O' The Beck
    BD23 1PH Skipton
    North Yorkshire
    British100972090001
    MURISON, Robert William
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    সচিব
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    British97871790001
    RAWLINSON, Paul Victor
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    সচিব
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    BritishAccountant12127500003
    SHANKLEY, Alan Forbes
    34 Queens Road
    LS29 9QJ Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    34 Queens Road
    LS29 9QJ Ilkley
    West Yorkshire
    British7591870001
    WISHART, Charles George Mackenzie
    3 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    সচিব
    3 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    BritishCompany Director60654460001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    BANKS, Duncan Stuart
    Prospect Road
    AL1 2AT St. Albans
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Prospect Road
    AL1 2AT St. Albans
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishMortgage Broker135148110001
    BARRETT, Peter Charles
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishManaging Director94805030001
    BOLTON, Richard Peter
    37 Claremount Gardens
    KT18 5XF Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    37 Claremount Gardens
    KT18 5XF Epsom
    Surrey
    BritishSales Director63844170002
    COGGAN, Imogen Frances Lytton
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    পরিচালক
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant134061130001
    DARBY, Ian Stuart
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector77702700004
    DARBY, Ian Stuart
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishCommercial Director77702700004
    EATWELL, Emma
    37 Woodcote House
    Updown Hill
    RH16 4GQ Haywards Heath
    West Sussex
    পরিচালক
    37 Woodcote House
    Updown Hill
    RH16 4GQ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishSales Director126637850001
    FRASER, Richard Cullen
    8 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    পরিচালক
    8 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector49677170001
    FRENKEL, John Richard
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    পরিচালক
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    BritishAccountant127384780001
    HODGSON, Candice Juliet
    Flat 7
    8 Nevern Square
    SW5 9NW London
    পরিচালক
    Flat 7
    8 Nevern Square
    SW5 9NW London
    South AfricanMarketing Director102118810001
    JONES, Trevor
    37 Harley Street
    W1G 8QG London
    পরিচালক
    37 Harley Street
    W1G 8QG London
    BritishCompany Director102230160001
    KENNEDY, Ian David
    Abacus
    Lansdown Road
    BA1 5TD Bath
    পরিচালক
    Abacus
    Lansdown Road
    BA1 5TD Bath
    United KingdomBritishCeo93804080003
    KORNITZER, Clive David
    4 Parham Way
    Muswell Hill
    N10 2AT London
    পরিচালক
    4 Parham Way
    Muswell Hill
    N10 2AT London
    United KingdomBritishChief Operating Officer78559240001
    MATTHEWS, Colin
    10 St Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    পরিচালক
    10 St Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    EnglandBritishAccountant65470880001
    MCINERNEY, Jeremy James
    18 Crossgate Mews
    Harrow Molsey
    SK4 3AP Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    18 Crossgate Mews
    Harrow Molsey
    SK4 3AP Stockport
    Cheshire
    BritishSales & Marketing Director56718130001
    MCMAHON, Jane Elizabeth
    Sailmakers Court
    William Morris Court
    SW6 2UX London
    19
    United Kingdom
    পরিচালক
    Sailmakers Court
    William Morris Court
    SW6 2UX London
    19
    United Kingdom
    EnglandBritishCompliance Director56812870005
    MURISON, Robert William
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    পরিচালক
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    EnglandBritishAccountant97871790001
    OKEY, Ricky John
    72 Wattleton Road
    HP9 1RY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    72 Wattleton Road
    HP9 1RY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager94706140001
    PALMER, Martin John
    15 Beaconsfield Road
    BS8 2TS Bristol
    পরিচালক
    15 Beaconsfield Road
    BS8 2TS Bristol
    EnglandBritishCommercial Director105086120001
    PARKER, Paul
    9 Chestnut Walk
    Groby
    LE6 0EU Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    9 Chestnut Walk
    Groby
    LE6 0EU Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector65440140001
    RAWLINSON, Paul Victor
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    পরিচালক
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    BritishAccountant12127500003
    SCOTT, Keith Royston
    Goffs Farm London Road
    Northchapel
    GU28 9EQ Petworth
    West Sussex
    পরিচালক
    Goffs Farm London Road
    Northchapel
    GU28 9EQ Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director62864200003
    SHARPE, Robert
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    পরিচালক
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishCompany Director79424780004
    SHUTTLEWORTH, Barbara Mary
    30 Sandringham Road
    Boothstown Worsley
    M28 1LX Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    30 Sandringham Road
    Boothstown Worsley
    M28 1LX Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant49147640001

    CHARCOL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jon Moulton Charles Wishart and John Garfield
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জানু, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জানু, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Insurance policies, investments and receivables see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jon Moulton, Charles Wishart and John Garfield
    ব্যবসায়
    • ২৬ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £24,494 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rent deposit and the amount standing from time to time to the credit of a designated deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Universal Pension Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CHARCOL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৩ ফেব, ২০১০প্রশাসন শুরু
    ২৩ ফেব, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৩ ফেব, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৩ জানু, ২০১২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0