C. SHIPPAM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামC. SHIPPAM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03403946
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    C. SHIPPAM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    C. SHIPPAM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    C. SHIPPAM LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    EQUIPOFFER LIMITED১৬ জুল, ১৯৯৭১৬ জুল, ১৯৯৭

    C. SHIPPAM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২৩

    C. SHIPPAM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Cameron John Mackintosh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ০৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Cameron John Mackintosh-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ফেব, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen David Cardall-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ ফেব, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tatsuo Okura এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ ফেব, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Stephen David Cardall-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Tatsuo Okura-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kazuhito Suematsu এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Kazuhito Suematsu এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১০ জুল, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Kazuhito Suematsu-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Kazuhito Suematsu-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    C. SHIPPAM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CARDALL, Stephen David
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    সচিব
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    319754680001
    CARDALL, Stephen David
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    United KingdomBritishChief Financial Officer228519590001
    ITO, Kazuo
    Greenlands
    35-37 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    Greenlands
    35-37 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    JapaneseCompany Director76001510002
    MARSHALL, Christopher Alan
    Main Cottage Church Farm
    Idridgehay
    DE56 2SJ Belper
    Derbyshire
    সচিব
    Main Cottage Church Farm
    Idridgehay
    DE56 2SJ Belper
    Derbyshire
    BritishBusinessman54759450001
    NARITA, Koichi
    80 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    80 Hazelwood Road
    SK9 2QA Wilmslow
    Cheshire
    JapaneseDirector46902850002
    ODA, Manabu
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    সচিব
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    JapaneseDirector121331430003
    OWENS, David Anthony
    10 Guildford Place
    PO19 5DU Chichester
    West Sussex
    সচিব
    10 Guildford Place
    PO19 5DU Chichester
    West Sussex
    British112234240001
    SUEMATSU, Kazuhito
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    সচিব
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    245142520001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    কর্পোরেট সচিব
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    38508390002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Simon
    52 Bonser Road
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    52 Bonser Road
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector63589260001
    BROOKE, Stephen Robert Kemp
    14 Middle Drive
    Moorgate
    S60 3DJ Rotherham
    Yorkshire
    পরিচালক
    14 Middle Drive
    Moorgate
    S60 3DJ Rotherham
    Yorkshire
    BritishDirector60722400001
    CRITCHLEY, Kenneth David
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    United KingdomBritishCompany Director52787640001
    HARRISON, John David
    Greenside Cottage Lower Wyke Green
    Wyke
    BD12 9AD Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Greenside Cottage Lower Wyke Green
    Wyke
    BD12 9AD Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector44234890001
    ITO, Kazuo
    Greenlands
    35-37 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Greenlands
    35-37 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomJapaneseCompany Director76001510002
    JOLLY, Timothy Michael
    36 New Road
    Digswell
    AL6 0AH Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    36 New Road
    Digswell
    AL6 0AH Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector146550090001
    JOSEPH, Steven Falcon
    Orchard Close
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Orchard Close
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishBusinessman61618650001
    MACKINTOSH, Cameron John
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    EnglandBritishManaging Director146972900001
    MARSHALL, Christopher Alan
    Main Cottage Church Farm
    Idridgehay
    DE56 2SJ Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    Main Cottage Church Farm
    Idridgehay
    DE56 2SJ Belper
    Derbyshire
    BritishBusinessman54759450001
    MCNUTT, Geoffrey
    2 Far Meadow Way
    PO10 7PA Emsworth
    Hampshire
    পরিচালক
    2 Far Meadow Way
    PO10 7PA Emsworth
    Hampshire
    BritishBusinessman72070490001
    MEEK, Perry Dennis
    31 Cobden Avenue
    WR4 0NA Worcester
    পরিচালক
    31 Cobden Avenue
    WR4 0NA Worcester
    BritishBusinessman78932690002
    MUTCH, John Ashton
    94 Scarisbrick New Road
    PR8 6LQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    94 Scarisbrick New Road
    PR8 6LQ Southport
    Merseyside
    BritishChairman52787570001
    NARITA, Koichi
    101 Quebec Quay
    L3 4ER Liverpool
    পরিচালক
    101 Quebec Quay
    L3 4ER Liverpool
    JapaneseDirector46902850003
    ODA, Manabu
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    EnglandJapaneseDirector121331430006
    OKURA, Tatsuo
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    EnglandJapaneseDirector294308050001
    OWENS, David Anthony
    10 Guildford Place
    PO19 5DU Chichester
    West Sussex
    পরিচালক
    10 Guildford Place
    PO19 5DU Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishFinance Director112234240001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    পরিচালক
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    EnglandBritishSolicitor40718770002
    SUEMATSU, Kazuhito
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    পরিচালক
    Royal Liver Building
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    EnglandJapaneseDirector245135180001
    TWINE, Raymond
    White Cottage
    9 Apple Grove, Aldwick Bay Estate
    PO21 4NB Bognor Regis
    West Sussex
    পরিচালক
    White Cottage
    9 Apple Grove, Aldwick Bay Estate
    PO21 4NB Bognor Regis
    West Sussex
    BritishBusinessman106761880001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    C. SHIPPAM LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Princes Limited
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    Royal Liver Building
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Pier Head
    L3 1NX Liverpool
    Royal Liver Building
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegistrar Of Companies
    নিবন্ধন নম্বর2328824
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    C. SHIPPAM LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties) and to the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please refer to form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a plot 11 terminus road industrial estate chichester and the proceeds of sale thereof and allbuildings trade and erections thereon and all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited (as Security Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to all or any of the secured documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage l/h plot 11 terminus road industrial estate chichester and the proceeds of sale thereof and all buildings trade and erections and all fixtures whatsoever now or at any time herafter affixed or attached to the property or any part thereof belonging to or charged to the chargor.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Keyman insurance assignment
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the secured documents (the "secured obligations")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Interest in and to the policy and the proceeds and the full benefit thereof. Any re-assignment of the policy. Life assured steven joseph with effect from 9/9/97, for £50,000 3 years term with guardian financial services policy number LO190083201.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as equipoffer limited) to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited (as Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trade marks charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as equipoffer limited) to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge in favour of the bank the united kingdom registered trade marks listed in the trade marks charge (the "trade marks") together with any other rights which arise from or relate to the trade marks or with their use in the business of the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland; As Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as equipoffer limited) to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland; As Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0