CIVICA IT SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCIVICA IT SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03417245
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SANDERSON SYSTEMS LIMITED০১ অক্টো, ১৯৯৭০১ অক্টো, ১৯৯৭
    BROOMCO (1334) LIMITED১১ আগ, ১৯৯৭১১ আগ, ১৯৯৭

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৩

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ মার্চ, ২০১৫

    ১১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ মার্চ, ২০১৪

    ১৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০৪ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Simon Richard Downing-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Phillip David Rowland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Michael Stoddard এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    সচিব
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    British72002400004
    DOWNING, Simon Richard
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    পরিচালক
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    EnglandBritish95005230002
    ROWLAND, Phillip David
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    পরিচালক
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    United KingdomBritish147804610001
    FROST, Adrian David
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74874640001
    NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    সচিব
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    British29772430003
    STEWART, Caroline Elizabeth
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    সচিব
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    British52912910002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BEER, Peter James
    9 High Ash Crescent
    LS17 8RP Leeds
    Yorkshire
    পরিচালক
    9 High Ash Crescent
    LS17 8RP Leeds
    Yorkshire
    EnglandBritish56245440001
    DEWIS, Brian John
    Wychend
    Grange Road
    SL6 9RW Cookham
    Berkshire
    পরিচালক
    Wychend
    Grange Road
    SL6 9RW Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish30266880002
    HODKINSON, Allan Leslie
    195 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    195 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British21839900001
    KENDRICK-ASTLE, Pamela Elizabeth
    105 Brambling,
    Wilnecote
    B77 5PG Tamworth
    Staffordshire
    পরিচালক
    105 Brambling,
    Wilnecote
    B77 5PG Tamworth
    Staffordshire
    British65220350001
    NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish29772430003
    STEWART, Caroline Elizabeth
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    British52912910002
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish72002400004
    WATSON, David John
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    পরিচালক
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    British45073610001
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    পরিচালক
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ৩০ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee)
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ৩০ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০১ জুন, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৮ এপ্রি, ২০১৬ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0