ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামASHBURY CONFECTIONERY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03429285
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (1584) /

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Geoffrey Paul Rowley
    Vantis PO BOX 2653
    W1A 3RT 66 Wigmore Street
    London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ASHBURY HOLDINGS LIMITED১৭ ডিসে, ১৯৯৭১৭ ডিসে, ১৯৯৭
    OFFSHELF 246 LTD০৪ সেপ, ১৯৯৭০৪ সেপ, ১৯৯৭

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৬

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72

    ২৯ জুল, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৯ জানু, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৯ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২২ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    13 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    13 পৃষ্ঠা2.34B

    ০৩ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    13 পৃষ্ঠা2.24B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    12 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    41 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    27 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    27 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    23 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    27 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    9 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা123

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GEE, David Malcolm
    65 Leicester Road
    Groby
    LE6 0DQ Leicester
    সচিব
    65 Leicester Road
    Groby
    LE6 0DQ Leicester
    BritishFinance Director97831530001
    GEE, David Malcolm
    65 Leicester Road
    Groby
    LE6 0DQ Leicester
    পরিচালক
    65 Leicester Road
    Groby
    LE6 0DQ Leicester
    EnglandBritishFinance Director97831530001
    LAZENBY, David
    127 Coates Road
    Eastrea Whittlesey
    PE7 2BD Peterborough
    পরিচালক
    127 Coates Road
    Eastrea Whittlesey
    PE7 2BD Peterborough
    BritishProduction Director50005270001
    SEARS BLACK, Roderick Clive
    1 Brockway East
    Tattenhall
    CH3 9EY Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    1 Brockway East
    Tattenhall
    CH3 9EY Chester
    Cheshire
    BritishDirector81099680001
    ZULMAN, Arnold Norman
    355 Musgrave Road
    FOREIGN Durban
    4001
    South Africa
    পরিচালক
    355 Musgrave Road
    FOREIGN Durban
    4001
    South Africa
    South AfricanDirector64151110001
    ZULMAN, David Jeffrey
    Fircrest
    95 Uphill Road
    NW7 4QD Mill Hill
    London
    পরিচালক
    Fircrest
    95 Uphill Road
    NW7 4QD Mill Hill
    London
    United KingdomBritishCompany Director56665860002
    LEACH, Elaine
    The Roost Woodford Road
    Great Addington
    NN14 4BS Kettering
    Northamptonshire
    সচিব
    The Roost Woodford Road
    Great Addington
    NN14 4BS Kettering
    Northamptonshire
    British44883810001
    ROBERTS, Peter
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector9010990001
    OTHERS INTERESTS LIMITED
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Hanley Stoke On Trent
    Staffordshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Hanley Stoke On Trent
    Staffordshire
    900008520001
    BOLLAND, Martin Keith
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    পরিচালক
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    BritishAccountant54898960001
    CATER, Eric John
    Five Oaks Common Lane
    The Ridge Little Baddow
    CM3 4RY Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Five Oaks Common Lane
    The Ridge Little Baddow
    CM3 4RY Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishVenture Capitalist79393220001
    COFFEY, Sean
    4 Tarragon Way
    Exeter Street
    PE10 9NA Bourne
    Lincolnshire
    পরিচালক
    4 Tarragon Way
    Exeter Street
    PE10 9NA Bourne
    Lincolnshire
    IrishSales Director88093940002
    DONOHOE, Steven John
    2 Mitchell Street
    NN16 9HA Kettering
    Northamptonshire
    পরিচালক
    2 Mitchell Street
    NN16 9HA Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector76746960001
    GIANNOTTA, Mario
    Friars Stile Cross Lane
    Burton Lazars
    LE14 2UH Melton Mowbray
    Leicestershire
    পরিচালক
    Friars Stile Cross Lane
    Burton Lazars
    LE14 2UH Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishManaging Director50782420002
    HARTLEY, Peter
    Field View
    Paddock Farm Lane Bodicote
    OX15 4BT Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Field View
    Paddock Farm Lane Bodicote
    OX15 4BT Banbury
    Oxfordshire
    BritishSales Director39555550001
    HUTTON, Christopher Gerard
    Rose Lawn 181 Stonald Road
    Whittlesey
    PE7 1QG Peterborough
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Rose Lawn 181 Stonald Road
    Whittlesey
    PE7 1QG Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishAccountant31979010003
    ROBERTS, Peter
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector9010990001
    ZULMAN, Jonathan
    355 Musgrave Road
    Durban
    4001
    South Africa
    পরিচালক
    355 Musgrave Road
    Durban
    4001
    South Africa
    South AfricanCompany Director72316110001
    OFFSHELF LIMITED
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Hanley Stoke On Trent
    Staffordshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Hanley Stoke On Trent
    Staffordshire
    900008510001

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Autofeed 1 system including 1 portasilo mild steel one tonne sugar hopper with apv auto feeder (1989),1 apv 150-180KG twin chamber batch weighing system 2 stainless steel chambers (1989),4 apv 800KG stainless steel slurry tanks (1989) (for details of further chattels charged please refer to form 395) all plant,machinery and euipment and spare parts,replacements and modifications. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Investec Bank (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deposit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee charges the debt owing to the company by the bank on the account with the bank numbered 12382503,. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Investec Bank (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Albany Associates Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge over all assets
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in and to the f/h & l/h property of the company and all buildings fixtures fixed plant and machinery; all shares and securities; all moneys payable to the company and all other rights the company may have under a business finance agreement dated 11/07/00; all right title property and interest (if any) that the company may have in and to the debts and to the related rights.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nmb-Heller Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a all of the equipment listed hobart PR801 mixer no.731109, Harvester hl-111100 mixer no.98010008, Colsec insulated cold room. (For further details of the property charged please refer to the schedule of the form 395) a first fixed charge on all manuals title documents and spare parts relating to the said equipment, all guarantees warranties and representations and all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Bank London Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Bank London Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equipment mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the agreement or any document supplemental thereto including this mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One - aasted book chocolate moulding plant; one - chocolate tank; two - chocolate tempering kettles. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eldorado Development Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land on the south side of steel road corby northamptonshire - NN127602 and all buildings and fixtures all rights easements and privileges insurance policy on the propery and goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nmb-Heller Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as ashbury holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge all the undertaking, assets stock in trade and its uncalled capital together with the proceeds and products thereof but excluding any receivables or related rights (as defined in the agreement) the ownership of which vests in.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Credit Services Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge on receivables and related rights
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as ashbury holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed equitable charge all factored receivables which fail to vest effectively and absolutely in the security holder pursuant to the agreement.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Credit Services Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as ashbury holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Bank London Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Wrapping machine cmy 551CB 55O6CB/2953; tevopharm multi-pack 2362 1147018; winkworth 2 arm mixer (serial no. 15599); bradman-lake model SL90 end load cartoner (bag in a box) complete with conveyor system 1997 (serial no. 5703797) (for details of further chattels please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal mortgage over land at willowbrook industrial estate corby northamptonshire t/n-NN127602. Fixed equitable charge over any other property. Fixed charge over plant machinery furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ashbury Stock Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as ashbury holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eldorado Development LTD
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on south side of steel road corby northants t/no: NN127602. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ASHBURY CONFECTIONERY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ জানু, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    ৩০ জুল, ২০০৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Geoffrey Paul Rowley
    Vantis
    66 Wigmore Street
    W1U 2SB London
    অভ্যাসকারী
    Vantis
    66 Wigmore Street
    W1U 2SB London
    Nicholas H O'Reilly
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    অভ্যাসকারী
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    2
    তারিখপ্রকার
    ৩০ জুল, ২০০৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৫ ফেব, ২০১১ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nicholas H O'Reilly
    Frp Advisory Llp Po Box
    2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    অভ্যাসকারী
    Frp Advisory Llp Po Box
    2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    Vantis
    Po Box 2653
    W1A 3RT 66 Wigmore Street
    London
    অভ্যাসকারী
    Vantis
    Po Box 2653
    W1A 3RT 66 Wigmore Street
    London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0