MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03430458
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DE FACTO 659 LIMITED০৮ সেপ, ১৯৯৭০৮ সেপ, ১৯৯৭

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১৪ সেপ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    ১৮ জুল, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 135 Bishopsgate London EC2M 3UR থেকে 280 Bishopsgate London EC2M 4RBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৯ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    3 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    3 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১৮ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jocelyn Nadauld Brushfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ অক্টো, ২০১৫

    ০১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,896,980.9
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter Edmund Lord-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Timothy John Clibbens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ সেপ, ২০১৪

    ১৭ সেপ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,896,980.9
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ সেপ, ২০১৩

    ২৬ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,896,980.9
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Rbs Secretarial Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে Carolyn Down এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ সেপ, ২০১১ তারিখে Miss Carolyn Jean Whittaker-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    কর্পোরেট সচিব
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC269847
    169073830001
    LORD, Peter Edmund
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    পরিচালক
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishFinance House Manager195549570001
    ROWNEY, James Mccubbin
    12-13 St. Andrew Square
    EH2 2AF Edinburgh
    Capital Building
    Scotland
    পরিচালক
    12-13 St. Andrew Square
    EH2 2AF Edinburgh
    Capital Building
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official59551350002
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    সচিব
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    সচিব
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Other67499700004
    ELTON, Christopher Peter
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    সচিব
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    BritishDirector47237180002
    FRANKS, Ian Charles
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    সচিব
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    British71584820001
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    সচিব
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    British34423910002
    RICHARDS, Timothy John
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    সচিব
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British,CanadianFinancial Director71050390002
    WATKINS, David Russell
    3 Cowdery Heights
    RG24 7AN Old Basing
    Hampshire
    সচিব
    3 Cowdery Heights
    RG24 7AN Old Basing
    Hampshire
    WelshDirector79082110001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BAILEY, Robert Andrew
    Bechers
    Withybed Lane
    WR7 4JJ Inkberrow
    Worcestershire
    পরিচালক
    Bechers
    Withybed Lane
    WR7 4JJ Inkberrow
    Worcestershire
    United KingdomBritishBanker104106520002
    BALDOCK, Alexander David
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    পরিচালক
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    United KingdomBritishBank Official132330380001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    পরিচালক
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritishBank Official137736080001
    BOOTH, Thomas John
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    পরিচালক
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    BritishManaging Director104299390001
    BRUSHFIELD, Jocelyn Nadauld
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    পরিচালক
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    EnglandBritishBank Official160922120001
    CLARKE, Robert
    14 Ernle Road
    Wimbledon Common
    SW20 0HJ London
    পরিচালক
    14 Ernle Road
    Wimbledon Common
    SW20 0HJ London
    BritishFund Manager40894440003
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant49141230004
    DIXON, Paul William Henry
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    পরিচালক
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector153357310001
    DIXON, Simon Timothy
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector101291990002
    ELTON, Christopher Peter
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    পরিচালক
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    EnglandBritishDirector47237180002
    GARDNER, John
    The Claydons
    3 The Close
    HP18 0HX Ashendon
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Claydons
    3 The Close
    HP18 0HX Ashendon
    Buckinghamshire
    BritishDirector76322860004
    GAYNOR, Alan Paul
    6 Ashampstead Ashwood Place
    Ashwood Road
    GU22 7JR Woking
    Surrey
    পরিচালক
    6 Ashampstead Ashwood Place
    Ashwood Road
    GU22 7JR Woking
    Surrey
    IrishDirector76771650002
    HAISMAN, Keith
    The Brick House
    Hermitage Meadow
    CO10 8QQ Clare
    Suffolk
    পরিচালক
    The Brick House
    Hermitage Meadow
    CO10 8QQ Clare
    Suffolk
    EnglandBritishBanker150598270001
    HUNTSMAN, Oliver John Harold
    11 Redan Street
    W14 0AB London
    পরিচালক
    11 Redan Street
    W14 0AB London
    EnglandBritishDirector14457860001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    পরিচালক
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritishBank Official122158360001
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    পরিচালক
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    EnglandBritishChartered Secretary34423910002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrishManaging Director100755360001
    MOSLEY, Ian Christopher
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector81842870001
    PARKINSON, Alan Donald
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker104435050001
    PATTERN, Adrian Leonard
    14 Broadacre Park
    HU15 1LT Brough
    North Humberside
    পরিচালক
    14 Broadacre Park
    HU15 1LT Brough
    North Humberside
    EnglandBritishChartered Accountant76387530001
    PEPPARD, Anthony Edward
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    IrishManager76520410001
    PUTTICK, Robert Stephen
    Appledown Beacon Hill Road
    GU26 6QD Hindhead
    Surrey
    পরিচালক
    Appledown Beacon Hill Road
    GU26 6QD Hindhead
    Surrey
    BritishDirector64459530003
    RAMANATHAN, Shankar
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker125663610001
    RICHARDS, Timothy John
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish,CanadianFinancial Director71050390002

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Dixon Motorcycle Holdings Limited
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    EC2M 4RB London
    280 Bishopsgate
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষ1985-1989
    নিবন্ধিত স্থানRegister Of Members
    নিবন্ধন নম্বর04338560
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MOTORSPORT DEALERS INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of accession between motorsport dealers international limited, dixon motors PLC and the royal bank of scotland PLC
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each lender under each designated finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a group company) to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 6TH november 1997 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to the policies and all monies including bonuses accrued;- policies being 1). policy no 3625668E with the scottish provident institution on the life of robert stephen puttick for £125,000 2). no 3625704C with scottish provident institution on robert alan weir for £125,000 3). no 3628798D with scottish provident institution on david russell watkins for £250,000 4). no 2979811LY with general accident on robert alan weir for £125,000 5). no 2980902LY with general accident on edward henry morris lemco for £250,000 6). no Y0030/02 with cassidy davis life syndicate on robert alan weir and robert stphen puttick for £500,000 and 6). no X49639598 with standard life on edward henry morris lemco for £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture ("the deed")
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other group company as defined to the chargee under this deed as defined therein (the "secured obligations")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property at lynchford road, farnborough, hampshire; clapham high street, london; staines road, bedfont, middlesex; portsmouth, hampshire; oxford road, reading; seven sisters road, london; ruislip road east, greenford, middlesex; russell hill road, purley way, purley, surrey; ford lane, salford, manchester; bristol hill, brislington, bristol; great portland street, london; 336 battersea park road, london; bevois valley road, southampton. (See form M395 and schedules for details of all the property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries as Defined in the Facilities Agreement) ("the Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee facility (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in all monies standing to the credit of the account number 91250279 at the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Plcin Its Capacity as Issuing Bank Under the Facility Agreement
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0