THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03437534
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হোটেল এবং অনুরূপ থাকার জায়গা (55100) / সংস্থাপন এবং খাদ্য পরিষেবা কার্যক্রম

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MYLOHILL LIMITED২২ সেপ, ১৯৯৭২২ সেপ, ১৯৯৭

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১৬
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০১৭
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৫

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 034375340017 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 034375340016 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ জানু, ২০১৬

    ১৯ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Wfw Legal Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা One Fleet Place London EC4M 7WS থেকে 15 Appold Street London EC2A 2HBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    চার্জ 034375340015 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gary Reginald Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ ডিসে, ২০১৪

    ২৩ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা One Fleet Place London EC4M 7WS এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 034375340017 এর অংশ নয়

    5 পৃষ্ঠাMR05

    সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 034375340016 এর অংশ নয়

    5 পৃষ্ঠাMR05

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 034375340015 এর অংশ নয়

    5 পৃষ্ঠাMR05

    চার্জ নিবন্ধন 034375340017

    18 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ নিবন্ধন 034375340016

    18 পৃষ্ঠাMR01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    11 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    চার্জ নিবন্ধন 034375340015

    93 পৃষ্ঠাMR01

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1648390
    18093320001
    ROBERTS, Paul
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    পরিচালক
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    United KingdomBritishFinance Director168184220001
    ADAMS, Denise
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    সচিব
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    British54657810001
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    সচিব
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    সচিব
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    কর্পোরেট সচিব
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    পরিচালক
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritishCompany Director34251500001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    পরিচালক
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritishCompany Director34251500001
    BATE, Simon Donald
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    পরিচালক
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    BritishManagement Consultant75874130002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director9320160002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor9320160002
    BLACK, Robin Kennedy
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    পরিচালক
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant37965380001
    BLUM, Edward Jesse
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    AmericanEvp-Finance65674420001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    পরিচালক
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director53724380001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishCompany Director53724380001
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    পরিচালক
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    AmericanCorporate Counsel65674380001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    পরিচালক
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    BritishCompany Director38255700004
    CANNON, Phyliss
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    পরিচালক
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    BritishCo Services Manager55712040001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    পরিচালক
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    AmericanDirector & Company Officer66262660001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector102741680001
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    পরিচালক
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritishChief Executive Officer136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    পরিচালক
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    EnglandBritishCeo167510270002
    DODD, Andrew Gerard
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    EnglandBritishBusiness Manager74768570001
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishFinance Director154267590001
    HAINING, Andrew
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    পরিচালক
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    BritishInvestment Banker42196640008
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    পরিচালক
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritishCompany Director69263980002
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    পরিচালক
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritishDirector69263980002
    MCCULLOCH, Kenneth Wilfred
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    পরিচালক
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    ScotlandBritishHotelier37947170001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector132613500001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    পরিচালক
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    AmericanDirector66261390001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    পরিচালক
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilianCompany Director51723030002
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    পরিচালক
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilianCompany Director51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    পরিচালক
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritishCompany Director121710890001

    THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Malmaison (edinburgh) 1 tower place edinburgh t/no.MID102835.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৮ নভে, ২০১৪সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ৩০ আগ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Malmaison (edinburgh) (one) 1 tower place edinburgh t/no.MID113519. (Two) 1-4 tower place t/no.MID91315 and (three) northeast side of tower street edinburgh t/no.MID12575.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৮ নভে, ২০১৪সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ৩০ আগ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৮ নভে, ২০১৪সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২২ জুন, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Original Lenders and the Agent) (the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28TH june 2006 and
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the companys interest in a lease of the land with buildings erected thereon known as malmaison edinburgh 1 tower place leith edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Malmaison hotel 1 tower place leith edinburgh EH6 7DB. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 9TH june 2003 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole (in the first place) the subjects at tower place/tower street leith lying for the purposes of registration of writs in the county of midlothian shown outlined red on the plan annexed and executed as relative to the disposition by (firstly) international transport limited and (secondly) forth ports PLC in favour of the malmaison company (edinburgh) limited dated 18 and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the count of midlothian on 26 both days of march 1998. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 july 2002 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due from mwb malmaison holdings limited (the "borrower") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The malmaison hotel,tower place/tower street,leith,edinburgh in the county of midlothian.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 july 2002 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The malmaison hotel,tower place/tower street,leith,edinburgh in the county of midlothian.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property and undertaking of the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 march 2001 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and/or future obligations and liabilities of mwb hotel properties limited (the borrower) pursuant to the loan agreement between the borrower and hotel invest UK a/s and all liabilities of the company pursuant to this debenture and all liabilities of any group company to sas hotel management limited in respect of fees pursuant to hotel management agreements
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole that area in the county midlothian with buildings thereon extending to 0.35 acres lying in tower place leith, all and whole 0.338 acres lying to the south of tower stret lane, leith.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hotel Invest UK a/S
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Third party debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or mwb hotel properties limited under or pursuant to the loan agreement and all liabilities of the chargor pursuant to the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hotel Invest UK a/S
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 november 2000 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies obligations and liabilities of mwb hotel properties limited (the "borrower") to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined) and all liabilities of the chargor pursuant to the standard security
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The subjects at tower place/tower street,leith lying in the county of midlothian with all buildings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Societe Generale,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Standardsecurity)
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Third party debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of mwb hotel properties limited to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined) and all liabilities of the company pursuant to the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Societe Generale (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 1998 and
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The malmaison hotel tower place/tower street leith edinburgh midlothian.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company(As Agent and Trustee of Itself and the Securedparties)
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of admission to composite guarantee indemnity and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (to be renamed the malmaison company (edinburgh) limited) to the chargee in its capacity as agent and trustee for the secured parties (the security trustee) under or pursuant to the financing documents (as defined) including all its liabilities under clause 3 of the security (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0