ENERGIS PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামENERGIS PLC
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03438871
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ENERGIS PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6420) /

    ENERGIS PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 More London Place
    London
    SE1 2AF
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ENERGIS PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENERGIS GROUP PLC১৮ সেপ, ১৯৯৭১৮ সেপ, ১৯৯৭

    ENERGIS PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০০৩
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ অক্টো, ২০০৩
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে

    ENERGIS PLC এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৮ সেপ, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০২ অক্টো, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    ENERGIS PLC এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    ENERGIS PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    16 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    17 পৃষ্ঠাWU07

    ২৭ ফেব, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Ian Wickham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    15 পৃষ্ঠাWU07

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    5 পৃষ্ঠাWU04

    লিকুইডেটর অপসারণের নোটিশ আদালত দ্বারা

    4 পৃষ্ঠাWU14

    লিকুইডেটর অপসারণের নোটিশ আদালত দ্বারা

    4 পৃষ্ঠাWU14

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    15 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    14 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    20 পৃষ্ঠাWU07

    ২৮ ফেব, ২০১৯ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    প্রশাসনিক আদেশের মুক্তির নোটিশ

    3 পৃষ্ঠা2.19

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাWU04

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    5 পৃষ্ঠাCOCOMP

    ১৫ জানু, ২০১৯ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জুল, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জুল, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ১৫ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা2.15

    ENERGIS PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HIBBERT, John Christopher
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    সচিব
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    BritishAccountant6236200001
    MARTIN, Jonathan Terence
    3 Lavender Close
    CM23 4LN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    সচিব
    3 Lavender Close
    CM23 4LN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British54775070002
    ASTLE, Edward Morrison
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68674100002
    ASTLE, Edward Morrison
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68674100002
    ASTLE, Edward Morrison
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68674100002
    ASTLE, Edward Morrison
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Bailey Farmhouse
    Chatham Green, Little Waltham
    CM3 3LE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishSales Director68674100002
    BEAUMONT, John Richard
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    পরিচালক
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    BritishBusiness Manager92701330001
    BOX, Stephen John
    Great Dewlands
    Dewlands Hill
    TN6 3RU Rotherfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Great Dewlands
    Dewlands Hill
    TN6 3RU Rotherfield
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director10280950003
    CALLISTER RADCLIFFE, John Nicholas
    30 Ruskin Walk
    Dulwich
    SE24 9LZ London
    পরিচালক
    30 Ruskin Walk
    Dulwich
    SE24 9LZ London
    United KingdomBritishSolicitor48876420001
    GRABINER, Michael
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    পরিচালক
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    United KingdomBritishChief Executive82032360001
    HIBBERT, John Christopher
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    পরিচালক
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    BritishAccountant6236200001
    JONES, David Harold
    Wylmington Hayes
    Wilmington
    EX14 9JZ Honiton
    Devon
    পরিচালক
    Wylmington Hayes
    Wilmington
    EX14 9JZ Honiton
    Devon
    EnglandBritishCompany Director75454360002
    JONES, David Harold
    Hemmick Court
    Queen Street Hale
    SP6 2RD Fordingbridge
    Hampshire
    পরিচালক
    Hemmick Court
    Queen Street Hale
    SP6 2RD Fordingbridge
    Hampshire
    BritishCompany Director75454360001
    MARTIN, Jonathan Terence
    3 Lavender Close
    CM23 4LN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    3 Lavender Close
    CM23 4LN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishSolicitor54775070002
    OWEN, Gordon Michael William
    Sutton End House
    RH20 1PY Sutton
    West Sussex
    পরিচালক
    Sutton End House
    RH20 1PY Sutton
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director76695740003
    RODRIGUES, Christopher John
    131 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8LA London
    পরিচালক
    131 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8LA London
    BritishCompany Director48116480001
    TAYLOR, Robert
    109 Gloucester Avenue
    Primrose Hill
    NW1 8LB London
    পরিচালক
    109 Gloucester Avenue
    Primrose Hill
    NW1 8LB London
    BritishDirector77834960001
    TRENT, William Edward James
    57 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    পরিচালক
    57 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    United KingdomBritishCompany Director81249170001
    URWIN, Roger John, Dr
    Treetops 14 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    পরিচালক
    Treetops 14 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishEngineer1487440001
    WALMSLEY, Nigel Norman
    Belsize Road
    NW6 4RD London
    28
    পরিচালক
    Belsize Road
    NW6 4RD London
    28
    EnglandBritishCompany Director2530680001
    WICKHAM, David Ian
    Galleons
    16 Homestead Road
    BR6 6HW Orpington
    Kent
    পরিচালক
    Galleons
    16 Homestead Road
    BR6 6HW Orpington
    Kent
    EnglandBritishC.O.O.68123400001

    ENERGIS PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over deposit accounts
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums now or hereafter standing to the credit of any accounts of the company prefixed "cibc re energis PLC" with the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cibc World Markets PLC (The "Energis Trustee") on Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Parties to the Loan Agreement
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barclays euro treasury deposit ref LD50394815. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of debenture and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the toronto-dominion bank (for itself and its successors in title and assigns and as agent and trustee for the secured parties) all monies due or to become due from the company and energis communications limited to the security trustee or any secured party on any account whatsoever under the terms of the facility agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a first floor offices 185 park street london second third fourth fifth floors 185 park street london l/h property k/a unit 8 sunset business centre manchester road kearsley greater manchester and all the other properties listed in the schedule to the 395 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Toronto-Dominion Bank (For Itself and Its Successors in Title and Assigns and as Agent Andtrustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ মে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ENERGIS PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ জুল, ২০০২প্রশাসন শুরু
    ২৮ ফেব, ২০১৯প্রশাসন বরখাস্ত
    প্রশাসনিক আদেশ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Margaret Elizabeth Mills
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    অভ্যাসকারী
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Michael David Rollings
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    অভ্যাসকারী
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৬ জানু, ২০১৯আবেদন তারিখ
    ২৮ ফেব, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Margaret Elizabeth Mills
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    অভ্যাসকারী
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Simon J Edel
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Joanne Robinson
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0