TRIBAL NC LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTRIBAL NC LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03442665
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TRIBAL NC LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা কার্যক্রম (70229) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    TRIBAL NC LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TRIBAL NC LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEWCHURCH LIMITED০৪ অক্টো, ২০০০০৪ অক্টো, ২০০০
    AGORA HEALTHCARE SERVICES LIMITED০১ অক্টো, ১৯৯৭০১ অক্টো, ১৯৯৭

    TRIBAL NC LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    TRIBAL NC LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    TRIBAL NC LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২৮ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    4 পৃষ্ঠাSH19

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium & other reserves reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robert Charles Garner-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Keith Martin Evans এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩১ মার্চ, ২০১৫

    ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    ০৫ জুন, ২০১৪ তারিখে Mr Stephen Derrick Breach-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ আগ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR থেকে Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩১ মার্চ, ২০১৪

    ৩১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Lorraine Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed newchurch LIMITED\certificate issued on 24/05/11
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৪ মে, ২০১১

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২০ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    পরিচালক হিসাবে Dr Keith Martin Evans-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    TRIBAL NC LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    পরিচালক
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    পরিচালক
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish53391420003
    ANDO, Daniella
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British51693570001
    COLLINS, Richard Hawke
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    সচিব
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    British136546790001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    সচিব
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    150939960001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    সচিব
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    British60400060001
    HERCUS, Ivan Lindsay
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    সচিব
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    British116757120001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    সচিব
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    সচিব
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    WARNER, Evelyn Patricia
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    সচিব
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    British129486480001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CONAGHAN, John Edward, Mr.
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    পরিচালক
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish97327390002
    DEWEY, Kevin
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    British6631200001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    পরিচালক
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritish159812510001
    FIELD, Andrew
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    পরিচালক
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish61471170001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    পরিচালক
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    GODBER, Stephen Alison
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    পরিচালক
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish105071600001
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish60400060001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    পরিচালক
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    British13396990001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    পরিচালক
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritish124153720001
    KEY, Simon Robert
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish41514390002
    KHAN, Junaid
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    British98917630001
    LAMBERT, Susan
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    পরিচালক
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    British113974450001
    LAWTON, Simon Marcus
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    পরিচালক
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish68807890004
    MANNING, Kingsley Guy
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    পরিচালক
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    United KingdomBritish15931310003
    MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    পরিচালক
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    British23175310002
    MARTIN, Peter John
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    পরিচালক
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish176044430001
    SALLIS, David
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    United KingdomUk44780590002
    SETCHELL, Brenda Carol
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    পরিচালক
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United KingdomBritish90477860001
    STONE, Lisa Jane
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    পরিচালক
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish69455810002
    TOLLEY, Robyn William
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    পরিচালক
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    British95294050001
    TRICKEY, Philip John
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    পরিচালক
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    EnglandBritish72857220001
    WILLIAMS, Richard John
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    পরিচালক
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    British64882280001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TRIBAL NC LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The interest bearing sterling deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Laminglade Limited and Laminpark Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hg Investment Managers Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rowan Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All other goodwill in the UK and elsewhere worldwide and the unregistered trade marks and trade names,the core software and the architecture software. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the beneficiaries under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation from time to time granted
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barclays bank PLC re agora healthcare services limited barclays high interest business account number 30648299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation under the terms of this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৪ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0