DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03444409
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্য কোথাও শ্রেণীবদ্ধ নয় এমন আর্থিক মধ্যস্থতা (64999) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৯

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    7 পৃষ্ঠাLIQ13

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২২ জুল, ২০২১ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    7 পৃষ্ঠাLIQ01

    ১৩ জুল, ২০২১ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 56,341,654
    4 পৃষ্ঠাSH01

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ সেপ, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Neeraj Kapur-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon George Thomas এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ সেপ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ ডিসে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Charles Fisher এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ ডিসে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon George Thomas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ সেপ, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৬ জুল, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr David George Whincup-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    legacy

    পৃষ্ঠাANNOTATION

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Paula Watts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WHINCUP, David George
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    সচিব
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    249464050001
    KAPUR, Neeraj
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    Provident Financial Plc
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    Provident Financial Plc
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish268623050001
    LE MAY, Malcolm John
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43422720003
    MARSHALL SMITH, Rosamond Joy
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    সচিব
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    British17986770001
    MEYRICK, Stephen John
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    সচিব
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    British106205110001
    NEWBY, Leonard John
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    সচিব
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    British55084420001
    VERSLUYS, Emma Gayle
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British102724740003
    WATTS, Paula
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    সচিব
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    232277070001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    COOPER, Julian Edward Peregrine
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    পরিচালক
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    United KingdomBritish91049680001
    CROOK, Peter Stuart
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109187730001
    DUNKLEY, Paul John
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritish34398930002
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    British77093570001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    British77093570001
    FISHER, Andrew Charles
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish41331580002
    GLEN, Robert John
    5 High Meadows
    Firth Lane Wilsden
    BD15 0HN Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    5 High Meadows
    Firth Lane Wilsden
    BD15 0HN Bradford
    West Yorkshire
    EnglandUnited Kingdom87214920001
    HARRISON, Richard
    97 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    97 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British100892740002
    JOHNSTONE, Christopher Charles
    Pine Lodge
    Castle Lane Ripponden
    HX6 4JZ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Pine Lodge
    Castle Lane Ripponden
    HX6 4JZ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British53747580002
    LINDSEY, Ian Walter
    3 Kinderscout
    HP3 8HW Leverstock Green
    Hertfordshire
    পরিচালক
    3 Kinderscout
    HP3 8HW Leverstock Green
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85980860001
    MACLEOD, Gregory Ian
    Murrayfield
    13 Windsor Road
    SL9 7NB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Murrayfield
    13 Windsor Road
    SL9 7NB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MARSHALL SMITH, Rosamond Joy
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    British17986770001
    MEYRICK, Stephen John
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    British106205110001
    NEWBY, Anthony Charles
    Millhouse
    Church Road, Woolton
    L25 6DA Liverpool
    পরিচালক
    Millhouse
    Church Road, Woolton
    L25 6DA Liverpool
    British54172180002
    NEWBY, Anthony
    51 Wheatcroft Road
    Allerton
    L18 9UF Liverpool
    পরিচালক
    51 Wheatcroft Road
    Allerton
    L18 9UF Liverpool
    British54172180001
    NEWBY, Leonard John
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    পরিচালক
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    British55084420001
    PARSONAGE, Robert David
    Homeleigh
    10 Chart Way
    RH2 0NZ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    Homeleigh
    10 Chart Way
    RH2 0NZ Reigate
    Surrey
    British108363060001
    PLOWMAN, Stephen Russell
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish76672190002
    PLOWMAN, Stephen Russell
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish76672190002
    PRINCE, Joseph Michael
    Keffolds
    44 Tongdean Avenue
    BN3 6TN Hove
    East Sussex
    পরিচালক
    Keffolds
    44 Tongdean Avenue
    BN3 6TN Hove
    East Sussex
    British71867540003
    PRINCE, Joseph Michael
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    British71867540001
    SHAW, Simon Andrew
    Horrocks Close
    BD20 8HQ Lothersdale
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Horrocks Close
    BD20 8HQ Lothersdale
    North Yorkshire
    UkBritish87062650001
    THOMAS, Simon George
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    EnglandBritish253188120001
    THORNTON, John Rolfe
    Kirk Lea
    Main Street
    HG5 9LD Staveley
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Kirk Lea
    Main Street
    HG5 9LD Staveley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish147555560001
    WEBSTER, James Maxwell
    28d Cruden Street
    N1 8NH London
    পরিচালক
    28d Cruden Street
    N1 8NH London
    United KingdomBritish97036540001
    YATES, Stuart William
    81 Gunterstone Road
    West Kensington
    W14 9BT London
    পরিচালক
    81 Gunterstone Road
    West Kensington
    W14 9BT London
    EnglandBritish108370390001

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No 1 Godwin Street
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No 1 Godwin Street
    England
    না
    আইনি ফর্মPublic Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর668987
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title interest and benefit of the company in and to the scottish funded receivables. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Spartacus One, Inc
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title interest and benefit in and to the scottish funded receivables to the extent not previously assigned in favour of the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Spartacus One, Inc.
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Scottish trust security
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the debenture, the facility agreement, the transaction documents and such other documents (if any) as may constitute or evidence any of the secured obligations.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The funded receivables governed by scots law forming part of the funded receivables and all amounts becoming payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Spartacus One, Inc.
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Spartacus One, Inc.
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    First supplemental deed to composite guarantee and debenture dated 26 july 1999
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys, obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 26 july 1999, a composite guarantee and debenture dated 26 july 1999, a facility agreement dated 26 july 1999, an inter-creditor agreement dated 26 july 1999, a subordination deed 26 july 1999 and the first supplemental deed and any and all other mortgages, charges, guarantees and other instruments from time to time entered into by the parent and/or both/either of the borrowers by way of guarantee or other assurance of and/or security for amounts owed to the bank under the facility agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The debenture charges all the present and future assets of the company. First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types (a) land, interests in land and fixtures (b) plant, machinery and equipment (c) shares, bonds and other securities of any kind (d) debts and claims (e) the proceeds of collection of debts and claims and credit balances at banks (f) the benefit of insurances (g) goodwill and uncalled capital (h) intellectual property of all kinds in each case, together with all associated rights (the fixed charge). Excluded from the fixed charge are all of the undertakings, assets, interests, rights and benefits of the company which are charged by way of fixed charge in favour of spartacus one, incorporated pursuant to a debenture dated 8 march 2001. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC on Behalf of Itself and and the Banks Fromtime to Time Parties to the Facility Agreement
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee on behalf of itself and the banks from time to time parties to the facility agreement under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company and on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    K/A unit 2 monckton road industrial estate denby dale road, wakefield t/no: WYK592491 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২২ জুল, ২০২১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৬ জুল, ২০২২ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0