CAPARO ENGINEERING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAPARO ENGINEERING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03450375
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • লোহা ঢালাই (24510) / উৎপাদন
    • অন্যান্য নন-ফেরাস ধাতু ঢালাই (24540) / উৎপাদন
    • অন্যান্য প্রস্তুতকৃত ধাতব পণ্য উত্পাদন (25990) / উৎপাদন

    CAPARO ENGINEERING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SUPREMO 2000 LIMITED১৫ অক্টো, ১৯৯৭১৫ অক্টো, ১৯৯৭

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    23 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২৫ অক্টো, ২০২৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    23 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৫ অক্টো, ২০২২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:secreatary of state release of liquidator.
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    ২৫ অক্টো, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    23 পৃষ্ঠাLIQ03

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    15 পৃষ্ঠা600

    আদালতের আদেশ দ্বারা লিকুইডেটর অপসারণ

    13 পৃষ্ঠাLIQ10

    ২৫ অক্টো, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৫ অক্টো, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    25 পৃষ্ঠাLIQ03

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    আদালতের আদেশ দ্বারা লিকুইডেটর অপসারণ

    17 পৃষ্ঠাLIQ10

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    34 পৃষ্ঠাAM22

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    32 পৃষ্ঠাAM10

    ০৭ অক্টো, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 7 More London Riverside London SE1 2RT থেকে Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    29 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি

    11 পৃষ্ঠা2.38B

    ১৮ অক্টো, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    1 পৃষ্ঠা2.23B

    ১৮ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    32 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৭ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Derek Michael O'reilly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    পরিচালক
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    BENNETT, Paul Richard
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    সচিব
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    British76951010001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত সচিব
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    সচিব
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    British126516810001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    সচিব
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    BEATON, Kevin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish150211630001
    BOTTING, Richard Graham
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    পরিচালক
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    British85897150001
    BUTLER, Richard Gareth John
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish117859680001
    CLIFF, Richard Martyn
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    পরিচালক
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish56113440001
    CURRAN, James Thomas
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    পরিচালক
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    United KingdomBritish56844020001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    পরিচালক
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    GANE, Christopher Nigel
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    ScotlandBritish73268030001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HAMMOND, Christopher Mark
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish60992860002
    HARTLAND, Melvyn Edward
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    পরিচালক
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    British8436920002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    পরিচালক
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAUL, Akhil
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish199010800001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAY, Jason Christopher
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish126516810001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish126516810001
    PINCHES, Brian Michael
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    British44065140001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    TAYLOR, Paul
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish49786260004
    UNDERHILL, Maurice
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    পরিচালক
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    British12842580001
    WHALE, Ian
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish192902390001
    WOOD, John Franklin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    পরিচালক
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish1397720001
    WOOD, John Franklin
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish1397720001

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০১৪
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caparo PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ২০১৩
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property. Caparo testing, brenda road, hartlepool t/no CE52039.. Caparo forgoing, marriott road, dudley t/no WM383778. (For details of patents charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০১৩
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land at caparo testing brenda road hartlepool t/no CE52039. F/h land at caparo forging marriott road dudley t/no WM383778. Patent described as "mounting (cmt own shock absorber)" filed in 1998 with number GB2330642. For details of further intellectual property please refer to deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Polish law registered pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000 (say: fifty million zlotys), all the rights. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caparo PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Polish law registered pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000 (say: ten million euro), all the rights. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jalia Holding S.A.
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caparo PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jalia Holding Sa
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৩ জুল, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    CAPARO ENGINEERING LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ অক্টো, ২০১৫প্রশাসন শুরু
    ২৬ অক্টো, ২০১৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৬ অক্টো, ২০১৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২১ মে, ২০২৪ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0