RAL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামRAL REALISATIONS 2011 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03474127
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (3614) /
    • (3615) /

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    REST ASSURED LIMITED২৯ জানু, ১৯৯৮২৯ জানু, ১৯৯৮
    PINCO 996 LIMITED০১ ডিসে, ১৯৯৭০১ ডিসে, ১৯৯৭

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জানু, ২০১০

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ আগ, ২০১১

    ২৮ আগ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 700,000
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Paul Mckoen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Paul Mckoen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Paul Mckoen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed rest assured LIMITED\certificate issued on 15/06/11
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৮ জুন, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    legacy

    12 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Neal Gerard Mernock-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৬ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Paul Seth Mckoen-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৬ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Paul Seth Mckoen-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ০২ ফেব, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MERNOCK, Neal Gerard
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    পরিচালক
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    United KingdomBritish67905570005
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    British106771550001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    সচিব
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    British68949300004
    HOPE, Richard Geoffrey
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    সচিব
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    British32541300001
    JONES, Robert Glyn
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    সচিব
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    British116871110002
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    সচিব
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    British49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    সচিব
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish106771550001
    ALLENZA, Antonino
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British39237330004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    CLARK, Andrew William
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomEnglish102836380001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    পরিচালক
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritish68949300004
    GILL, Stephen Paul
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    পরিচালক
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    British59486300001
    IDDON, Joanne
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish92755390001
    MCILROY, Michael
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    পরিচালক
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    British63014400001
    MCKENZIE, Barry
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    পরিচালক
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    British1164360001
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    পরিচালক
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    EnglandBritish49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    SCOTT, Michelle
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British51740980003
    SIMPSON, William
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish14163900002
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    British36252860002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    RAL REALISATIONS 2011 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the cahrgors to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Grace Bay Ii Holdings Sarl
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0