INGLEBY (1045) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINGLEBY (1045) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03485429
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INGLEBY (1045) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7222) /

    INGLEBY (1045) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    6th Floor 4 Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INGLEBY (1045) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VERTEX LIMITED২৭ জুন, ২০০৮২৭ জুন, ২০০৮
    INGLEBY (1045) LIMITED২৪ ডিসে, ১৯৯৭২৪ ডিসে, ১৯৯৭

    INGLEBY (1045) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১০

    INGLEBY (1045) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ জানু, ২০১১

    ০৬ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 21,186.94
    SH01

    ১৭ ডিসে, ২০১০ তারিখে Paul Terence Sweeny-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    6 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    6 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    6 পৃষ্ঠাMG02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Jeffrey Chittenden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Jeffrey Chittenden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed vertex LIMITED\certificate issued on 13/01/09
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    INGLEBY (1045) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHEFFIELD, Anne Louise
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    সচিব
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    British85634660002
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish44173560008
    SWEENY, Paul Terence
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    পরিচালক
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    United KingdomBritish140303320002
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    সচিব
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BIRKETT, Timothy Lloyd
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    সচিব
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    British99698140001
    CROFT, Christopher Rendell
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    সচিব
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    British55143000001
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    সচিব
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    British79149580001
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    সচিব
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    সচিব
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British41061870001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    UU SECRETARIAT LIMITED
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    কর্পোরেট সচিব
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    94063410003
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    পরিচালক
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    CHITTENDEN, Jeffrey George John
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    পরিচালক
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United KingdomBritish123115670003
    DRURY, Thomas Waterworth
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish/Canadian29701240002
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish79149580001
    GALES, David Robert
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    British22498240002
    GITTINS, John Anthony
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish164311370001
    GRAHAM, Richard Halton
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    পরিচালক
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Canadian120665310001
    GREEN, Stephen Nathaniel
    9 Woodcocks
    TN27 9HB Headcorn
    Kent
    পরিচালক
    9 Woodcocks
    TN27 9HB Headcorn
    Kent
    British62499540001
    HUNT, Andrew James
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54503850003
    JONES, Martin Peter William
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    British15332330002
    SHEPHERD, Dale Stanley
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    পরিচালক
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    American124135650001
    SYMONDS, Christine Ann
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British24999120002
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    পরিচালক
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    United KingdomBritish41061870002
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    INGLEBY (1045) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan note instrument constituting £10,422,500 9% secured loan notes together with interest and any other monies incurred by the security agent or any noteholder in relation to the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Apax Partners & Co. Ventures(As Security Agent for Itself and the Noteholders)
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture to secure 9% £4,986,000 fixed rate "b" loan notes
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gerald Michael Whitmore,as Security Agent for Himself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture to secure 9% £1,632,000 fixed rate "c" loan notes
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Christine Ann Symonds,as Security Agent for Herself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    36,495 a ordinary shares of £1. 729,900 10P a ordinary shares & 13,505 b ordinary shares of £1 in the capital of crisp computing limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from ingleby (1045) limited and crisp computing limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0