PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03486675
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7310) /

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PHOQUS PHARMACEUTICALS LIMITED২৭ নভে, ২০০২২৭ নভে, ২০০২
    PHOQUS LIMITED২৯ ডিসে, ১৯৯৭২৯ ডিসে, ১৯৯৭

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৭

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72

    ২২ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    8 পৃষ্ঠা2.16B

    ১৬ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    11 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    11 পৃষ্ঠা2.34B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    10 পৃষ্ঠাMA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed phoqus pharmaceuticals LIMITED\certificate issued on 18/09/07
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    8 পৃষ্ঠা395

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish70796290001
    LEATHERS, David Frederick James
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    পরিচালক
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    EnglandBritish84070000003
    MASON, Richard Colin St Helier, Dr
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    British122520900001
    MOSES, Edwin, Dr
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    পরিচালক
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    British78748090004
    BRACE, Jacqueline Anne
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    সচিব
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    British56818020001
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    সচিব
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    British70796290001
    SMITH, Suzanne Elaine
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    সচিব
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    British119288360001
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    ARMSTRONG, Frank Murdoch, Dr
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    পরিচালক
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    British79589620003
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    American34371910001
    BLAKER, Graham Joseph, Dr
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish110270002
    BLANEY, Terence William Daniel
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    পরিচালক
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    United KingdomBritish8680200001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CLOSE, Jon
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    পরিচালক
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    British78001370001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    পরিচালক
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    পরিচালক
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    MCLELLAND, Michael Bruce
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    পরিচালক
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    American63138450001
    MOTZER, William Raymond
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    পরিচালক
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    American17570280001
    SEAGER, Harry, Dr
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    পরিচালক
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    British63260950001
    STANIFORTH, John Nicholas
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    পরিচালক
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    British116945380001
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    10 kings hill avenue kings hill west mal. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Oxford Finance Corporation
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit balance and all amount standing to the credit of an interest bearing account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kings Hill Trustee No 1 Limited and Kings Hill Trustee No 2 Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Liberty Property Limited Partnership
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from either obligor or both of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the right, title and interest in and to each machine and all related rights relating to each machine but excluding any intellectual property in the design or operation of the machines. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cardinal Health U.K. 416 Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gatx European Technology Ventures
    ব্যবসায়
    • ২৬ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held opened in the name of liberty property limited partnership.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Liberty Property Limited Partnership
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of rent deposit supplemental to a lease
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rouse Kent (Central) Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due owing or incurred by the company (whether as principal or surety) to the security trustee or any of the lenders pursuant to the terms of the investment agreement as amended from time to time dated 29/01/01
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the investment agreement dated 30 january 2001 ("the investment agreement") and/or the debenture (other than a dividend on any shares)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC ("the Security Trustee") (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gatx European Technology Ventures
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ নভে, ২০০০বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৬ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৭ জুল, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    ২৩ ফেব, ২০০৯প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৩ ফেব, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৫ জুন, ২০১০ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0