CAVAT II LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAVAT II LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03488517
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAVAT II LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    CAVAT II LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAVAT II LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KELOWN LIMITED০৫ জানু, ১৯৯৮০৫ জানু, ১৯৯৮

    CAVAT II LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    CAVAT II LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Timothy Roberts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Nigel Webb এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে James Taylor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Sarah Barzycki এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Peter Clarke এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Lucinda Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Graham Roberts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ জানু, ২০১০

    ২৮ জানু, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Jones এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    CAVAT II LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    সচিব
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    সচিব
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    BritishAccountant102349020001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    STONEMAN, Susan Elizabeth
    124 Rothwell Road
    Desborough
    NN14 2NT Kettering
    Northamptonshire
    সচিব
    124 Rothwell Road
    Desborough
    NN14 2NT Kettering
    Northamptonshire
    British38856170002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    পরিচালক
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    পরিচালক
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    পরিচালক
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    পরিচালক
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishCompany Secretary32809000002
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    পরিচালক
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    BritishAccountant42841550001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    BritishChartered Quantity Surveyor16914120001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    পরিচালক
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    AmericanExecutive Manager73545680001
    HERRTAGE, Nicholas Guy Greville
    24 Ellerton Road
    SW18 3NN London
    পরিচালক
    24 Ellerton Road
    SW18 3NN London
    EnglandBritishCompany Director56330650002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    পরিচালক
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritishBuilding Surveyor16914130001
    LEWINGTON, Keith Edward
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor40796190001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MOORE, Albert Richard Jr
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    পরিচালক
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    UsaManaging Director73545620001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    পরিচালক
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    পরিচালক
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    পরিচালক
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor63986410003
    TAYLOR, James Fielding
    115 Revelstoke Road
    Southfields
    SW18 5NN London
    পরিচালক
    115 Revelstoke Road
    Southfields
    SW18 5NN London
    EnglandBritishChartered Surveyor / Asset Man103617060002
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    পরিচালক
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001

    CAVAT II LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over beneficial interest
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a st peter's church cephas street london t/no: EGL351390.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services PLC, (The Security Trustee) and the Beneficiaries (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over beneficial interest
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities, due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or on any account whatsoever (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of security assignment each of the following including all rights of enforcement of the same. 1.The property being 9-11 eastcheap london EC3 t/nos LN12639 and LN67062. 7 steele road london W4 t/n AGL41715 and 184-188 north gower street london NW1 t/nos NGL68800 and NGL523431. 2.The rents. 3.The trust deed.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee for Thebeneficiaries Pursuant to the Facility Agreement)
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee all monies and liabilities due owing or incurred from london & henley UK limited (the "borrower") or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any account whatsoever (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services Plcacting as Trustee for the Beneficiaries Under the Facility Agreement ("the Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a land and buildings on the north-west side of cephas street stepney london egl 351390. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or cavendish geared ii PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 9 & 11 eastcheap london-EC3N 1BN. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 163 trinity road london t/no: TGL107537. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 7 overstone road london t/no: NGL507542. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 55 queens gardens london t/no: NGL724928. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 184 and 186 north gower street and 188 north gower street t/nos: NGL688100 and NGL523431. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 5 overstone road london t/no: LN121158. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 7 steele road london t/no: AGL41715. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0