VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03496478
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Fleetlands Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SIGMA AEROSPACE LIMITED০৩ আগ, ১৯৯৮০৩ আগ, ১৯৯৮
    CHC AIRMOTIVE LIMITED১১ ফেব, ১৯৯৮১১ ফেব, ১৯৯৮
    GLADNOTE LIMITED২১ জানু, ১৯৯৮২১ জানু, ১৯৯৮

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২০

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    ১৮ ফেব, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ফেব, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ফেব, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Chris Hosking এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Diane Mackey Roseborough-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brent Jeffrey Fawkes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Robert Scott-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gary Scott Carruthers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Griffith Jones-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ ফেব, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৬ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Owen Martin Mcclave এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    ১১ অক্টো, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Chris Hosking-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ আগ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Bryant এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ আগ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Paul Bryant এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১৮ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CARRUTHERS, Gary Scott
    Fareham Road
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    England
    পরিচালক
    Fareham Road
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    England
    United KingdomBritishFinance Director248343660001
    FAWKES, Brent Jeffrey
    Allen Dyne Road
    Winnipeg, Mb R3h 1a1
    33
    Canada
    পরিচালক
    Allen Dyne Road
    Winnipeg, Mb R3h 1a1
    33
    Canada
    CanadaCanadianVp Finance248343430001
    JONES, Simon Griffith
    Fareham Road
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    England
    পরিচালক
    Fareham Road
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    England
    United KingdomBritishManaging Director248343760001
    ROSEBOROUGH, Diane Mackey
    N. Scottsdale Road, Suite 250
    Scottsdale, Az 85253
    6710
    United States
    পরিচালক
    N. Scottsdale Road, Suite 250
    Scottsdale, Az 85253
    6710
    United States
    United StatesAmericanLegal Services Manager248343340001
    SCOTT, Michael Robert
    Allen Dyne Road
    Winnipeg, Mb R3h 1a1
    33
    Canada
    পরিচালক
    Allen Dyne Road
    Winnipeg, Mb R3h 1a1
    33
    Canada
    CanadaCanadianCfo182412620001
    BRAMMAN, Daniel
    2 Edward Mann Close East
    Caroline Street
    E1 0JS London
    সচিব
    2 Edward Mann Close East
    Caroline Street
    E1 0JS London
    British58067370001
    BRYANT, Paul
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    সচিব
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    British125276920001
    FRENCH, Jeannie Marie Helen
    8 Cassino Place
    St Johns
    A1A 3X3 Newfoundland
    Canada
    সচিব
    8 Cassino Place
    St Johns
    A1A 3X3 Newfoundland
    Canada
    CanadianDirector Of Tax & Ad79393070001
    FRENCH, Jeannie Marie Helen
    8 Cassino Place
    St Johns
    A1A 3X3 Newfoundland
    Canada
    সচিব
    8 Cassino Place
    St Johns
    A1A 3X3 Newfoundland
    Canada
    CanadianDirector Of Tax & Administrati79393070001
    PENNEY, Scott
    Flat 3, 98 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7BA London
    সচিব
    Flat 3, 98 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7BA London
    British97862620001
    PETTIPAS, Brian Andrew
    61a Belgrave Court
    36 Westferry Circus
    E14 8RL London
    Surrey
    সচিব
    61a Belgrave Court
    36 Westferry Circus
    E14 8RL London
    Surrey
    CanadianDirector Of Finance79003930001
    ROCKWOOD, Gerald
    Flat 6 Liane Court
    230 Pampisford Road
    CR2 6DB Croydon
    Surrey
    সচিব
    Flat 6 Liane Court
    230 Pampisford Road
    CR2 6DB Croydon
    Surrey
    CanadianDirector Of Finance87292080001
    ZUREL, Jo Mark
    4 Birmingham Street
    St Johns
    A1E 5C8 Newfoundland
    Canada
    সচিব
    4 Birmingham Street
    St Johns
    A1E 5C8 Newfoundland
    Canada
    CanadianCorporate Controller66464170001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    কর্পোরেট সচিব
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BRYANT, Paul
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    পরিচালক
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    UkBritishFinance Director125276920004
    BRYANT, Paul
    14 Topaz Grove
    Waterlooville
    PO7 8ST Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    14 Topaz Grove
    Waterlooville
    PO7 8ST Portsmouth
    Hampshire
    UkBritishCommercial Director125276920001
    CONWAY, Paul Joseph
    123 Rennies Road
    Saint Johns
    New Foundland
    Canada
    পরিচালক
    123 Rennies Road
    Saint Johns
    New Foundland
    Canada
    BritishCompany Director57146570003
    DOBBIN, Mark Douglas
    22 Circular Road
    St Johns
    A1C 2ZI New Foundland
    Canada
    পরিচালক
    22 Circular Road
    St Johns
    A1C 2ZI New Foundland
    Canada
    IrishCompany Director45849380001
    HOSKING, Chris
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    পরিচালক
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    United KingdomBritishNone239703610001
    JACKSON, Donald Kenneth
    105 Bedford Road
    M5C 2Y7 Toronto
    Ontario
    পরিচালক
    105 Bedford Road
    M5C 2Y7 Toronto
    Ontario
    CanadianExecutive96712190001
    JONES, Keith Goodwin
    30 Waterside
    RH6 8JE Horley
    Sussex
    পরিচালক
    30 Waterside
    RH6 8JE Horley
    Sussex
    British CanadianCompany Director82555150001
    JONES, Stephen Lambert
    Chalfonts
    Beaconsfield Road
    RH17 7LG Chelwood Gate
    East Sussex
    পরিচালক
    Chalfonts
    Beaconsfield Road
    RH17 7LG Chelwood Gate
    East Sussex
    BritishManaging Director58066950001
    LEVINE, Randal
    Toronto
    279 St. Clemens Avenue
    M4r 1h5 Ontario
    Canada
    পরিচালক
    Toronto
    279 St. Clemens Avenue
    M4r 1h5 Ontario
    Canada
    CanadianExecutive126386090005
    MCCLAVE, Owen Martin
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    পরিচালক
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    IrelandIrishManaging Director205997660001
    MERRIKIN, Barry
    Horseshoe Lodge
    Warsash
    SO31 9AY Southampton
    10
    Hampshire
    পরিচালক
    Horseshoe Lodge
    Warsash
    SO31 9AY Southampton
    10
    Hampshire
    UkBritishManaging Director65592070001
    MERRIKIN, Barry
    10 Horseshoe Lodge
    Warsash
    SO31 9AY Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    10 Horseshoe Lodge
    Warsash
    SO31 9AY Southampton
    Hampshire
    UkBritishManaging Director65592070001
    O'SHEA, Declan Gerard
    Fairyhouse Lodge
    Ratoath
    6
    Meath
    Ireland
    পরিচালক
    Fairyhouse Lodge
    Ratoath
    6
    Meath
    Ireland
    UkIrishPresident And Ceo Vector Aerospace141134300001
    PARSONS, Samuel Maxwell
    9 Brighton Place
    A1A 4W2 St Johns
    Newfoundland
    Canada
    পরিচালক
    9 Brighton Place
    A1A 4W2 St Johns
    Newfoundland
    Canada
    CanadianChief Financial Officer59117090001
    PRITCHARD, Trevor Glyn
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    পরিচালক
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    United KingdomBritishNone174681770002
    RICE, Timothy Julian
    Broadway Road
    GL54 5JN Winchcombe
    Chandos House
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Broadway Road
    GL54 5JN Winchcombe
    Chandos House
    Gloucestershire
    United KingdomBritishManaging Director78643990002
    ROCKWOOD, Gerald
    490 Glasgow Circle
    94526 Danville
    California
    Usa
    পরিচালক
    490 Glasgow Circle
    94526 Danville
    California
    Usa
    BritishDirector Of Finance98022860002
    TIERNEY, Peter
    Flat 1, 12 Kew Gardens Road
    Kew
    TW9 3HG Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    Flat 1, 12 Kew Gardens Road
    Kew
    TW9 3HG Richmond
    Surrey
    BritishManaging Director92067140001
    TYRRELL, Michael Kevin
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    পরিচালক
    Fareham Road
    Bld 140
    PO13 0AA Gosport
    Fleetlands
    Hampshire
    IrelandIrishManaging Director166836100001
    WATSON, Colin Dela Court
    72 Chestnut Park Road
    M4W 1W8 Toronto
    Ontario
    পরিচালক
    72 Chestnut Park Road
    M4W 1W8 Toronto
    Ontario
    CanadianExecutive96713000001

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Vector Aerospace (Uk Holdings) Limited
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1 Exchange Crescent
    Scotland
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1 Exchange Crescent
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    VECTOR AEROSPACE ENGINE SERVICES UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the f/h and l/h property under t/n SGL37263 and SGL578652. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vector Aerospace Corporation
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the f/h and l/h property under t/n SGL37263 and SGL578652. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Acro Aerospace Inc
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    An aerotest limited mobile engine test system incorporating a control cabin,test trailer and fuel storage tank. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land at dera pyestock farnborough hants. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a land at purley way industrial estate croydon airport l/b of sutton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £132,345.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coal Pension Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Joint and several guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from acro aerospace inc to the chargee in connection with a credit agreement dated 14TH april 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All debts and liabilities present and future of acro aerospace inc to the company and any monies received by the company in respect thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Joint and several guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness and liability which each of vector aerospace corporation, atlantic turbines international inc and acro aerospace inc has incurred or may incur or be under to the chargee in connection with a loan agreement dated 28TH may 1998 as amended supplemented replaced or otherwise modified from time to time and any documents and instruments delivered thereunder or collateral thereto and whether for principal interest fees expenses or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All debts and liabilities present and future of vector aerospace corporation, atlantic turbines international inc and acro aerospace inc to the company and sigma aerospace (holdings) limited and any monies received by the company and sigma aerospace (holdings) limited in respect thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings lying to the west of purley way waddon factory estate croydon T.n SGL37263. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H units 1B 1C 1D queensway waddon factory estate waddon t/n SGL587562. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings lying to the west of purley way waddon factory estate croydon t/n SGL37263. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H units 1B 1C 1D queensway waddon factory estate waddon t/n SGL587562. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 12 imperial way croydon t/n-SGL486129.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0