CARDPOINT SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCARDPOINT SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03516589
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    CARDPOINT SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED১৯ ফেব, ২০০৯১৯ ফেব, ২০০৯
    CARDPOINT SERVICES LIMITED২৩ অক্টো, ২০০৮২৩ অক্টো, ২০০৮
    MONEYBOX CORPORATION LIMITED১৭ জানু, ২০০০১৭ জানু, ২০০০
    MONEY BOX CORPORATION LIMITED২৫ ফেব, ১৯৯৮২৫ ফেব, ১৯৯৮

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Edward Keller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Christopher Brewster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Michael Edward Keller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মার্চ, ২০১৫

    ০৩ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England থেকে C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    ১৫ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jana Hile-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৭ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩০ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jeremy David Kraft এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ ফেব, ২০১৪

    ২৫ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,769,863.59
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    অডিটরের পদত্যাগ

    3 পৃষ্ঠাAUD

    পরিচালক হিসাবে Mr Jeremy David Kraft-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Michael Keller-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে John Christopher Brewster-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HILE, Jana
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    EnglandAustralian192111080001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110396210002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    সচিব
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    সচিব
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    সচিব
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    সচিব
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    পরিচালক
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    পরিচালক
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    DINSMORE, Rikki Gavin
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    পরিচালক
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    United KingdomBritish137100920001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HOLROYD, Richard Norton
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    পরিচালক
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    British80220410001
    ISAACS, Vincent
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    পরিচালক
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    British38705920001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    পরিচালক
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORGAN, Colin John
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    পরিচালক
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Irish70867300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    পরিচালক
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    পরিচালক
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    United KingdomBritish116252510001
    ROBSON, Vincent Martin
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    পরিচালক
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    British64602710001
    RYLAND, Stuart Antony
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    পরিচালক
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish74367340001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    পরিচালক
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    পরিচালক
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    পরিচালক
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    পরিচালক
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish99393670001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    CARDPOINT SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A confirmatory security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৯ আগ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৯ আগ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৫ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Agent or the Security Trustee). the Royalbank of Scotland the 'Original Pledgees'
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Syndicated debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustees for Thebeneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    52 authomated teller machines.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage of chattels
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0